KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED

KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02745667
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    • Educación preescolar (85100) / Educación
    • Actividades de cuidado diurno de niños (88910) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2 Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KINDERCARE LEARNING CENTRES LIMITED28 oct 199228 oct 1992
    KINDERCARE LEARNING CENTERS LIMITED02 sept 199202 sept 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 26 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 ene 2016

    Estado de capital el 26 ene 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 dic 2015

    Estado de capital el 18 dic 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 18 nov 2015

    • Capital: GBP 100
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account be cancelled 03/11/2015
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 12 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2015

    Estado de capital el 02 sept 2015

    • Capital: GBP 50,001
    SH01

    Cese del nombramiento de Mary Ann Tocio como director el 01 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    9 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 ago 2014

    Estado de capital el 28 ago 2014

    • Capital: GBP 50,001
    SH01

    Exercice comptable précédent raccourci du 10 abr 2014 au 31 dic 2013

    1 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 10 abr 2013

    32 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 sept 2013

    Estado de capital el 09 sept 2013

    • Capital: GBP 50,001
    SH01

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2013 au 10 abr 2013

    1 páginasAA01

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Nombramiento de Mr Stephen Dreier como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mary Ann Tocio como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Elizabeth Boland como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr David Lissy como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Stephen Kramer como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Claire Chadwick como secretario

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KRAMER, Stephen
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Secretario
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    177503500001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Director
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Director
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    United StatesAmerican170443250001
    LISSY, Dave
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Director
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    United StatesAmerican218331690001
    ARNOLD, Shane
    34 Highclove Lane
    M28 1GZ Worsley
    Lancashire
    Secretario
    34 Highclove Lane
    M28 1GZ Worsley
    Lancashire
    British106525210001
    BRYAN, Rebecca Shows
    3615 Hillview Close
    36106 Montgomery
    Alabama
    Usa
    Secretario
    3615 Hillview Close
    36106 Montgomery
    Alabama
    Usa
    American40945390002
    CHADWICK, Claire Marie
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Secretario
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    168032460001
    CHALMERS MORRIS, Stephen Geoffrey
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    Secretario
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    British58641010002
    COONER, Angela Denise Long
    8140 Westlakes Place
    Montgomery Alabama 36117
    FOREIGN United States Of America
    Secretario
    8140 Westlakes Place
    Montgomery Alabama 36117
    FOREIGN United States Of America
    American50788430001
    DE TENLEY, Elizabeth Carolyn
    16 Blencowe Close
    OX6 9UL Bicester
    Oxfordshire
    Secretario
    16 Blencowe Close
    OX6 9UL Bicester
    Oxfordshire
    American54873780001
    HARNETT, Charlotte Emma Claire
    7 Calves Close
    Shenley Brook End
    MK5 7HF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretario
    7 Calves Close
    Shenley Brook End
    MK5 7HF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British75093380001
    HUNTER, Amanda
    8 White Horse Yard
    NN12 6BX Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    8 White Horse Yard
    NN12 6BX Towcester
    Northamptonshire
    British84060330002
    KRIPALANI, Eva M
    3825 Sw Corbett
    97201 Portland
    Oregon
    Usa
    Secretario
    3825 Sw Corbett
    97201 Portland
    Oregon
    Usa
    Us Citizen55720080001
    MARSHALL, Rosamund Margaret
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    Secretario
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    British157022120001
    OTT, Keith Terry
    50 Gayton Road
    Hampstead
    NW3 1TU London
    Secretario
    50 Gayton Road
    Hampstead
    NW3 1TU London
    British35285110001
    PARNALL, Janet Lorraine
    4 Damson Close
    Walkwood
    B97 5WA Redditch
    Worcestershire
    Secretario
    4 Damson Close
    Walkwood
    B97 5WA Redditch
    Worcestershire
    British72392950001
    PEARSON, James Lee
    Rookery Cottages Chester Road
    Hartford
    CW8 1LL Northwich
    4
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario
    Rookery Cottages Chester Road
    Hartford
    CW8 1LL Northwich
    4
    Cheshire
    United Kingdom
    British185162450001
    THOMPSON, Paul Simon
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    Secretario
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    British149567830001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BACH, Karen
    Kent Street
    RH13 8BE Cowfold
    Potts Cottage
    W Sussex
    Uk
    Director
    Kent Street
    RH13 8BE Cowfold
    Potts Cottage
    W Sussex
    Uk
    United KingdomBritish160940730001
    BAILEY, William Esby
    3143 Lexington Road
    Montgomery Alabama 36106
    FOREIGN Usa
    Director
    3143 Lexington Road
    Montgomery Alabama 36106
    FOREIGN Usa
    American36131440001
    BRYAN, Rebecca Shows
    3615 Hillview Close
    36106 Montgomery
    Alabama
    Usa
    Director
    3615 Hillview Close
    36106 Montgomery
    Alabama
    Usa
    American40945390002
    CHALMERS MORRIS, Stephen Geoffrey
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    Director
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    British58641010002
    CLARK, Jeremy
    Willington Road
    Willington
    CW6 0ND Tarporley
    3 Oak Bank
    Cheshire
    England
    Director
    Willington Road
    Willington
    CW6 0ND Tarporley
    3 Oak Bank
    Cheshire
    England
    EnglandBritish153453360001
    DE TENLEY, Elizabeth Carolyn
    16 Blencowe Close
    OX6 9UL Bicester
    Oxfordshire
    Director
    16 Blencowe Close
    OX6 9UL Bicester
    Oxfordshire
    American54873780001
    GEARREALD JR, Tull Neal
    6025 Greystone Place
    36117 Montgomery
    Alabama
    United States Of America
    Director
    6025 Greystone Place
    36117 Montgomery
    Alabama
    United States Of America
    American40328290001
    HARNETT, Charlotte Emma Claire
    7 Calves Close
    Shenley Brook End
    MK5 7HF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    7 Calves Close
    Shenley Brook End
    MK5 7HF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British75093380001
    HIOTT, David Leeds
    7060 Knoll Loop Drive
    36116 Montgomery
    Alabama
    United States Of America
    Director
    7060 Knoll Loop Drive
    36116 Montgomery
    Alabama
    United States Of America
    American40328180001
    HOFFMANN, Mark Francis
    310 Boardwalk Place
    Park Ridge Illinois 60068
    FOREIGN United States Of America
    Director
    310 Boardwalk Place
    Park Ridge Illinois 60068
    FOREIGN United States Of America
    American50788350001
    HOLLOWAY, Adam Stuart
    Flat 1 231-5 Liverpool Road
    Islington
    N1 1LX London
    Director
    Flat 1 231-5 Liverpool Road
    Islington
    N1 1LX London
    United KingdomBritish80088960001
    HOUGHTON, Catherine Laura Jane
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Director
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish140056480001
    HUTCHINSON, Samuel Wray
    4235 Horton Road
    97068 West Linn
    Oregon
    Usa
    Director
    4235 Horton Road
    97068 West Linn
    Oregon
    Usa
    Us Citizen55720030002
    JOHNSON, David Jordan
    12621 Sw Edgecliff Road
    Portland Oregon
    FOREIGN Usa
    Director
    12621 Sw Edgecliff Road
    Portland Oregon
    FOREIGN Usa
    American54620270001
    KECK, Richard Paul
    69 Tranquil Vale
    Blackheath
    SE3 0BP London
    Director
    69 Tranquil Vale
    Blackheath
    SE3 0BP London
    Us Citizen41822340002
    KEDWARDS, David Charles
    Flat 13 Eaton Mews
    North Thirteenth Street
    MK9 3NR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    Flat 13 Eaton Mews
    North Thirteenth Street
    MK9 3NR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British67925060001

    ¿Tiene KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Group debenture
    Creado el 04 abr 2008
    Entregado el 12 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent (Security Agent)
    Transacciones
    • 12 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 15 nov 2007
    Entregado el 21 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 21 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 abr 2004
    Entregado el 13 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as kindercare learning centres limited to the charge on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Isis Equity Partners PLC
    Transacciones
    • 13 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 abr 2004
    Entregado el 30 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property known as land on the south side of callands road warrington cheshire t/n CH381916. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 abr 2004
    Entregado el 30 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property known as land on the south east side of quantock rise, t/n BD201472. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 abr 2004
    Entregado el 30 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Stock pledge and security agreement
    Creado el 09 jun 1995
    Entregado el 23 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The secured obligations (as defined therein) which are due or to become due from kindercare learning centers, inc. (The "borrower") to the chargee
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the stock held by the company being 1000 ordinary shares of £1 each in the capital of kindercare properties limited. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Toronto Dominion (Texas) Inc.as Agent for the Lenders and Facing Bank
    Transacciones
    • 23 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0