THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED

THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02748038
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Marstons House
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta02 oct 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Estado de capital el 07 sept 2022

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share premium account 05/09/2022
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 05 sept 2022

    • Capital: GBP 874,158
    3 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 27 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 oct 2021

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Anne Marie Brennan como secretario el 05 oct 2021

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Michelle Louise Woodall como secretario el 05 oct 2021

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Edward Hancock como director el 05 oct 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Robert Anthony Leach como director el 05 oct 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Hayleigh Lupino como director el 05 oct 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ralph Graham Findlay como director el 02 oct 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 27 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 03 oct 2020

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Richard James Westwood como director el 30 oct 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 27 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 sept 2019

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 sept 2018

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017

    8 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WOODALL, Michelle Louise
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Secretario
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    288186710001
    ANDREA, Andrew Andonis
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Director
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director137383120001
    HANCOCK, Edward John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Director
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor288133210001
    LEACH, Robert Anthony
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Director
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Treasury194085550001
    LUPINO, Hayleigh
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Director
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director207826950002
    ADAMS, Paul Francis
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Secretario
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    British125526410001
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    Secretario
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BRENNAN, Anne Marie
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Secretary109935620001
    BRYAN, Nicholas George
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    Secretario
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    BritishCompany Director65460520003
    SHAH, Vimal
    9 Southfield Road
    Chiswick
    W4 1AG London
    Secretario
    9 Southfield Road
    Chiswick
    W4 1AG London
    British4692040001
    WEST, Alan
    29 Oak Manor Drive
    GL52 6SZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    29 Oak Manor Drive
    GL52 6SZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishFinancial Controller111318570001
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    Secretario corporativo
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    106817380001
    ADAMS, Paul Francis
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Director
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    EnglandBritishChartered Accountant125526410001
    ANDREW, Derek
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Director
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director39071260003
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    Director
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BRYAN, Nicholas George
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    Director
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director65460520003
    CHOWDHARY, Balvinder Kaur
    112 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HR Hampton
    Middlesex
    Director
    112 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HR Hampton
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Registration Agent4672940001
    COYLE, James Arthur
    Glen Ruther College Road
    Denstone
    ST14 5HR Uttoxeter
    Staffordshire
    Director
    Glen Ruther College Road
    Denstone
    ST14 5HR Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishSales Director63364040001
    DALZELL, Peter
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Director
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director163616170001
    DARBY, Alistair William
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Director
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director87846880002
    DAVIES, Martin William Oliver
    Dancing Waters
    The Friary
    SL4 2NS Old Windsor
    Berkshire
    Director
    Dancing Waters
    The Friary
    SL4 2NS Old Windsor
    Berkshire
    BritishManaging Director40444030001
    DENNING, Roland John
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    Director
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director95991510001
    FINDLAY, Ralph Graham
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    Director
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director129897400001
    GRACE, David Allen
    Lark Rise Home Farm Court
    East End Adderbury
    OX17 3NW Banbury
    Oxon
    Director
    Lark Rise Home Farm Court
    East End Adderbury
    OX17 3NW Banbury
    Oxon
    BritishCompany Director67926560001
    HAWTHORN, Stuart John
    3 Rutherford Close
    OX14 2AT Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    3 Rutherford Close
    OX14 2AT Abingdon
    Oxfordshire
    BritishDirector82240190001
    INGLETT, Paul
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director81617110002
    LUSCOMBE, Richard William
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    Director
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    BritishCompany Director70464690001
    MOSS, Arthur Christopher
    80 Bridge Street
    OX2 0BD Oxford
    Oxfordshire
    Director
    80 Bridge Street
    OX2 0BD Oxford
    Oxfordshire
    BritishBrewer30700880001
    OLIVER, Stephen John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Director
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director66123690003
    ROGERS, Ian
    17 Burcott Park
    Burcott
    OX14 3DH Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    17 Burcott Park
    Burcott
    OX14 3DH Abingdon
    Oxfordshire
    BritishManaging Director30700870003
    THOMPSON, Rupert Geoffrey Ryland
    The Hermitage
    RG17 0HA Hungerford
    Berks
    Director
    The Hermitage
    RG17 0HA Hungerford
    Berks
    EnglandBritishCompany Director30939200001
    WESTWOOD, Richard James
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Director
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director314691870001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03981399
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creado el 08 jul 2002
    Entregado el 09 jul 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transacciones
    • 09 jul 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 12 jun 2002
    Entregado el 14 jun 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 nov 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Debenture
    Creado el 29 oct 1999
    Entregado el 10 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 ene 1998
    Entregado el 22 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Book debts debenture
    Creado el 28 oct 1996
    Entregado el 30 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future save for those book debts and other debts sold by the company and purchased by the chargee under an invoice discounting agreement and not purchased pursuant to the provisions thereof.
    Personas con derecho
    • New Court Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 30 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 abr 1995
    Entregado el 19 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Leasehold property known as units 10 and 11 eagle industrial estate the crofts witney oxfordshire title number ON172245 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 abr 1995
    Entregado el 19 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Leasehold property known as unit 12 eagle industrial estate witney oxfordshire title number ON169190 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 17 oct 1994
    Entregado el 21 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from hobgoblinns limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 21 oct 1994Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Counterpart rent deposit deed
    Creado el 11 ago 1994
    Entregado el 12 ago 1994
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of a lease dated 11TH august 1994 and this deed
    Breve descripción
    £1066 or one quarter of the annual rent from time to time payable under the said lease dated 11TH august 1994 (whichever shall be the greater) together with a sum equivalent to the rate of V.A.T. currently charged on rent.
    Personas con derecho
    • Hambridge Investments (Newbury) Limited
    Transacciones
    • 12 ago 1994Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed incorporating charge
    Creado el 12 may 1994
    Entregado el 13 may 1994
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of the lease dated 12TH may 1994.
    Breve descripción
    £5,529 and all other monies deposited in the deposit account at lloyds bank PLC in the name of the chargee.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hambridge Investments (Newbury) Limited
    Transacciones
    • 13 may 1994Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 01 jul 1993
    Entregado el 08 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 03 jun 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 24 jun 1993
    Entregado el 07 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H-unit 9B two rivers industrial estate station lane witney oxfordshire. T/n-ON111965 and ON139732 and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0