CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02752154 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | First Floor 2 Kingdom Street Paddington W2 6BD London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CAPITA SYMONDS INTERNATIONAL LIMITED | 16 feb 2011 | 16 feb 2011 |
| LEGACY FOR LONDON LIMITED | 22 ago 2008 | 22 ago 2008 |
| SYMONDS GROUP LIMITED | 16 jun 1993 | 16 jun 1993 |
| E.T.S. FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | 01 oct 1992 | 01 oct 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Capita Coporate Director Limited el 18 nov 2024 | 1 páginas | CH02 | ||
Cambio de datos del secretario Capita Group Secretary Limited el 18 nov 2024 | 1 páginas | CH04 | ||
Modification des détails de Capita Property and Infrastructure International Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 nov 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 65 Gresham Street London EC2V 7NQ England a First Floor 2 Kingdom Street Paddington London W2 6BD el 19 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 7 páginas | AA | ||
Nombramiento de Gemma Rebecca Bate-Williams como director el 14 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Elizabeth Helen Brownell como director el 19 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
legacy | 237 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 7 páginas | AA | ||
legacy | 235 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Stuart Ashburn como director el 14 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Elizabeth Helen Brownell como director el 14 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Francesca Anne Todd como director el 10 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Francesca Anne Todd como director el 03 ago 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Paddington W2 6BD London First Floor, 2 Kingdom Street England |
| 138426340001 | ||||||||||
| BATE-WILLIAMS, Gemma Rebecca | Director | 2 Kingdom Street Paddington W2 6BD London First Floor England | England | British | 291807800001 | |||||||||
| CAPITA COPORATE DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Paddington W2 6BD London First Floor, 2 Kingdom Street England |
| 130173870002 | ||||||||||
| CASTLE, Rodney Grahame | Secretario | The Old Cottage Wells Lane GU3 2BS Guildford Surrey | British | 4150130002 | ||||||||||
| FRANCE, Diana | Secretario | Flat 7 4 Clanricarde Gardens W2 4NA London | British | 55075330001 | ||||||||||
| HURST, Gordon Mark | Secretario | The Manor House Reading Road Padworth Common RG7 4QG Reading Berkshire | British | 60918000001 | ||||||||||
| PARMAR, Inderjit Singh | Secretario | 1 Barr Cottage Barr, Bishops Hull TA4 1AE Taunton Somerset | British | 67781960001 | ||||||||||
| CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | The Registry 34 Beckenham Road BR3 4TU Beckenham Kent | 102944500001 | |||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
| ASHBURN, Christopher Stuart | Director | EC2V 7NQ London 65 Gresham Street England | England | British | 331716020001 | |||||||||
| BERMEJO, Laurent Philippe | Director | 8 Woodville Road W5 2SF London | French | 66177700001 | ||||||||||
| BIDDLE, Norman Michael, Dr | Director | The Chantry 25 Church Road, Abbots Leigh BS8 3QP Bristol | United Kingdom | British | 35032440001 | |||||||||
| BOOY, Christopher Arthur | Director | Eastleach Station Road Portbury BS20 7TN Bristol Avon | United Kingdom | British | 42442390001 | |||||||||
| BROWNELL, Elizabeth Helen | Director | EC2V 7NQ London 65 Gresham Street England | England | British | 272617670001 | |||||||||
| CASE, Brynley Richard | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 179996610001 | |||||||||
| CHARLES-JONES, Lucinda Claire | Director | Flat 3 69 Sotheby Road Highbury N5 2UP London | British | 45975120001 | ||||||||||
| COWLEY, Graham | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 97173620002 | |||||||||
| COX, Anthony Hugh | Director | Marpool Farm Breadstone GL13 9HF Berkeley Gloucestershire | British | 36240920001 | ||||||||||
| DWYER, David Patrick | Director | Berners Street W1T 3LR London 30 England | United Kingdom | British | 201097350001 | |||||||||
| FERRETT, Anthony | Director | 10 Alderbrook Road B91 1NN Solihull West Midlands | British | 2839750001 | ||||||||||
| GORING, Jonathan Charles Bradbury | Director | Tumbling Bay Hamm Court KT13 8YE Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 39171090002 | |||||||||
| GREENSPAN, Daniel James | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 England | United Kingdom | British | 125130890002 | |||||||||
| HALE, Colin Stephen | Director | Woodlanders Haselor Lane Hinton On The Green WR11 6QZ Evesham Worcestershire | British | 45974890001 | ||||||||||
| HARDEN, Antony Kenneth | Director | Mathlin Cottage School Road Wrington BS18 7NB Bristol Avon | British | 45985920001 | ||||||||||
| HOWARD, Andrew David | Director | Berners Street W1T 3LR London 30 England | United Kingdom | British | 198552500001 | |||||||||
| HOWARD, Andrew David | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 198552500001 | |||||||||
| HURST, Gordon Mark | Director | The Registry 34 Beckenham Road BR3 4TU Beckenham Kent | British | 60918000003 | ||||||||||
| JARVIS, Ian Edward | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 184235890001 | |||||||||
| JENKINSON, Maurice Frederick | Director | 7 Hazelbank Cottages Ewhurst GU6 7RH Cranleigh Surrey | British | 63805230002 | ||||||||||
| JENNINGS, Timothy | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 | England | British | 149372130001 | |||||||||
| JONES, Elwyn Tudno | Director | Bryncoch Pendoylan CF71 7UJ Cowbridge South Glamorgan | British | 7341960001 | ||||||||||
| JONES, Oliver John | Director | 71 Cole Park Road TW1 1HT Twickenham Middlesex | British | 17483880002 | ||||||||||
| LEIGHTON, James Hunter | Director | 9 Llandennis Avenue Cyncoed CF2 6JG Cardiff | Wales | British | 35206230002 | |||||||||
| MARCHANT, Richard Melvyn | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 83241520001 | |||||||||
| MARCHANT, Richard Melvyn | Director | Orchard House 58 Spofforth Hill LS22 6SE Wetherby Leeds | England | British | 83241520001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CAPITA PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capita Property And Infrastructure International Holdings Limited | 06 abr 2016 | Paddington W2 6BD London First Floor, 2 Kingdom Street England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0