CRYSTALGLEN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCRYSTALGLEN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02753961
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CRYSTALGLEN LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra CRYSTALGLEN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Cavendish House Lakpur Court
    Staffordshire Techology Park
    ST18 0FX Stafford
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CRYSTALGLEN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CRYSTALGLEN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A693NN83

    Cese del nombramiento de John Henry Whitehead como director el 05 jun 2017

    1 páginasTM01
    X681IVLN

    Nombramiento de Mr Carl Michael Brown como director el 05 jun 2017

    2 páginasAP01
    X681IUZC

    Declaración de confirmación presentada el 25 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01
    X5GWBOG9

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    4 páginasAA
    A5FESC1M

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 ene 2016 au 31 dic 2015

    1 páginasAA01
    X4YUQGXL

    Cese del nombramiento de Timothy Mark Pethick como director el 31 dic 2015

    1 páginasTM01
    X4YUQ78I

    Cese del nombramiento de Victoria Haynes como secretario el 01 dic 2015

    1 páginasTM02
    X4LR1NIR

    Domicilio social registrado cambiado de Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE a Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Techology Park Stafford ST18 0FX el 03 dic 2015

    1 páginasAD01
    X4LGPNSI

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2015

    3 páginasAA
    A4H3HB7D

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 oct 2015

    Estado de capital el 01 oct 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01
    X4H3YJPV

    Nombramiento de Mr Timothy Mark Pethick como director el 09 sept 2015

    2 páginasAP01
    X4GLF87F

    Cese del nombramiento de Darryn Stanley Gibson como director el 09 sept 2015

    1 páginasTM01
    X4GLEFHG

    Cambio de datos del director Mr John Henry Whitehead el 01 mar 2014

    2 páginasCH01
    X4DS0PN7

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 nov 2014

    Estado de capital el 06 nov 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01
    X3K465PM

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2014

    3 páginasAA
    A3G3VW5E

    Nombramiento de Victoria Haynes como secretario

    2 páginasAP03
    X38XNKDF

    Cese del nombramiento de Taguma Ngondonga como secretario

    1 páginasTM02
    X38SBPMJ

    Nombramiento de Mr John Henry Whitehead como director

    2 páginasAP01
    X2Z9O0CX

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 oct 2013

    Estado de capital el 17 oct 2013

    • Capital: GBP 1,000
    SH01
    X2J63HKW

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2013

    4 páginasAA
    A2I06I9E

    Nombramiento de Darryn Stanley Gibson como director

    2 páginasAP01
    X2DX73WR

    Cese del nombramiento de Martyn Ellis como director

    1 páginasTM01
    X2DS21DS

    ¿Quiénes son los directivos de CRYSTALGLEN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BROWN, Carl Michael
    Lakpur Court
    Staffordshire Techology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    Director
    Lakpur Court
    Staffordshire Techology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant232841280001
    DAVIES, John
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    166848800001
    FLIGHT, Peter Michael
    2 Barnard Close
    Chislehurst
    BR7 6PQ Bromley
    Kent
    Secretario
    2 Barnard Close
    Chislehurst
    BR7 6PQ Bromley
    Kent
    BritishEmployment Consultant40811380001
    GIDALLA, Patricia
    Deepdene Greenwich Lane
    Ewell Minnis
    CT15 7EA Dover
    Kent
    Secretario
    Deepdene Greenwich Lane
    Ewell Minnis
    CT15 7EA Dover
    Kent
    BritishEmployment Consultant43907700001
    HAYNES, Victoria
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British182412280001
    MENNISS, John Patrick
    Yew Tree Cottage
    Ewell Minnis
    CT15 7DY Dover
    Kent
    Secretario
    Yew Tree Cottage
    Ewell Minnis
    CT15 7DY Dover
    Kent
    BritishProposed Director38998970001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Secretario
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    BritishDirector69603410001
    NGONDONGA, Taguma
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    171613910001
    WESTWOOD, Philip John
    Medicare House
    Stone Business Park Brooms Road
    ST15 0TL Stone
    Staffordshire
    Secretario
    Medicare House
    Stone Business Park Brooms Road
    ST15 0TL Stone
    Staffordshire
    BritishAccountant71727490001
    RAPID COMPANY SERVICES LIMITED
    Park House 64 West Ham Lane
    Stratford
    E15 4PT London
    Secretario designado corporativo
    Park House 64 West Ham Lane
    Stratford
    E15 4PT London
    900005530001
    BATEMAN, Stephen John
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishSupport Director133761180001
    ELLIS, Martyn Anthony
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director95749550002
    FISHER, Amanda Lucia
    The Rowans
    Merretts Orchard
    GL2 7DS Sumbridge
    Gloucestershire
    Director
    The Rowans
    Merretts Orchard
    GL2 7DS Sumbridge
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector174485990001
    FLIGHT, Peter Michael
    2 Barnard Close
    Chislehurst
    BR7 6PQ Bromley
    Kent
    Director
    2 Barnard Close
    Chislehurst
    BR7 6PQ Bromley
    Kent
    BritishEmployment Consultant40811380001
    GIBSON, Darryn Stanley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomNew ZealanderCompany Director177930490001
    GIDALLA, Patricia
    Deepdene Greenwich Lane
    Ewell Minnis
    CT15 7EA Dover
    Kent
    Director
    Deepdene Greenwich Lane
    Ewell Minnis
    CT15 7EA Dover
    Kent
    BritishEmployment Consultant43907700001
    JOHNSON, David Ian
    6 Mill Farm Court
    Chebsey
    ST21 6HZ Stafford
    Staffordshire
    Director
    6 Mill Farm Court
    Chebsey
    ST21 6HZ Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector46008570001
    MEDCRAFT, Marian Yvonne
    110 Leaves Green Road
    BR2 6DQ Keston
    Kent
    Director
    110 Leaves Green Road
    BR2 6DQ Keston
    Kent
    BritishMgt Acct70613030001
    MENNISS, John Patrick
    Deepdene
    Ewell Minnis
    CT15 7EA Dover
    Kent
    Director
    Deepdene
    Ewell Minnis
    CT15 7EA Dover
    Kent
    BritishEmployment Consultant38998970002
    MENNISS, John Patrick
    Yew Tree Cottage
    Ewell Minnis
    CT15 7DY Dover
    Kent
    Director
    Yew Tree Cottage
    Ewell Minnis
    CT15 7DY Dover
    Kent
    BritishProposed Director38998970001
    MOFFATT, David Stewart
    2 Lawrence Gardens
    Mill Hill
    NW7 4JT London
    Director
    2 Lawrence Gardens
    Mill Hill
    NW7 4JT London
    EnglandBritishAccountant88747420001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Director
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    BritishDirector69603410001
    PETHICK, Timothy Mark
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director172197670001
    TAYLOR, Kevin Lee
    8 Fairway
    Trentham
    ST4 8AS Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    8 Fairway
    Trentham
    ST4 8AS Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector111440290001
    WESTON, Paul David James
    Medicare House
    Stone Business Park Brooms Road
    ST15 0TL Stone
    Staffordshire
    Director
    Medicare House
    Stone Business Park Brooms Road
    ST15 0TL Stone
    Staffordshire
    United KingdomBritishFinance Director61904620002
    WHITEHEAD, John Henry
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant182872850002
    WILLOUGHBY, Marian Yvonne
    94 Caling Croft
    New Ash Green
    DA3 8PZ Longfield
    Kent
    Director
    94 Caling Croft
    New Ash Green
    DA3 8PZ Longfield
    Kent
    BritishProposed Director26673800001
    RAPID NOMINEES LIMITED
    Park House 64 West Ham Lane
    Stratford
    E15 4PT London
    Director designado corporativo
    Park House 64 West Ham Lane
    Stratford
    E15 4PT London
    900005520001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CRYSTALGLEN LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    25 sept 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene CRYSTALGLEN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating security document
    Creado el 19 jul 2004
    Entregado el 28 jul 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 28 jul 2004Registro de un cargo (395)
    A debenture executed in respect of a £45,500,000 senior facility agreement and dated 15 june 2001
    Creado el 15 jun 2001
    Entregado el 26 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations which the obligor may at any time have to the security agent (whether for its own account or on behalf of the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder, and the company shall pay to the security agent when due and payable every sum at any time owing, due or incurred by the obligor to the security agent (whether for its own account or on behalf of the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of such liabilities (all terms as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC, as Agent and Security Agent for and on Behalf of Thebeneficiaries on the Terms and Conditions Set Out in the Intercreditor Deed
    Transacciones
    • 26 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A debenture executed in respect of a £10,000,000 mezzanine facility agreement and dated 15 june 2001
    Creado el 15 jun 2001
    Entregado el 26 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations which the obligor may at any time have to the security agent (whether for its own account or on behalf of the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder, and the company shall pay to the security agent when due and payable every sum at any time owing, due or incurred by the obligor to the security agent (whether for its own account or on behalf of the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of such liabilities (all terms as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC, as Agent and Security Agent for and on Behalf of Thebeneficiaries on the Terms and Conditions Set Out in the Intercreditor Deed
    Transacciones
    • 26 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 27 jul 2000
    Entregado el 16 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 21 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over book debts
    Creado el 06 oct 1994
    Entregado el 18 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 4TH october 1994
    Breve descripción
    Any debt purchased by county factors limited which fails to vest absolutely in the factor . all other debts.
    Personas con derecho
    • County Factors Limited
    Transacciones
    • 18 oct 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over book debts
    Creado el 06 abr 1994
    Entregado el 08 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement dated 6TH april 1994
    Breve descripción
    Any debt purchased by county factors LTD which fails to vest absolutely in the factor and all other debts.
    Personas con derecho
    • County Factors Limited
    Transacciones
    • 08 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0