ST JAMES VILLAGE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ST JAMES VILLAGE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02760151 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ST JAMES VILLAGE LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra ST JAMES VILLAGE LIMITED?
Dirección de la sede social | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ST JAMES VILLAGE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
BONCOURT LIMITED | 29 oct 1992 | 29 oct 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ST JAMES VILLAGE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ST JAMES VILLAGE LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ST JAMES VILLAGE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Jonathan Ross Brodie el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP el 23 oct 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 15 dic 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Catchpole como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Jon William Mortimore como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 13 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ST JAMES VILLAGE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147807730001 | |||||||
BRODIE, Jonathan Ross | Director | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | England | British | Company Director | 62279790001 | ||||
LEWIS, Colin Edward | Director | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Wales | British | Director | 59395180001 | ||||
SHARP, Giles Henry | Director | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 194659450001 | ||||
FACER, John Leslie | Secretario | 29 Bovingdon Green Bovingdon HP3 0LB Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 33795700001 | ||||||
GANDHI, Devendra | Secretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | Director | 75350600002 | |||||
JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
MALDE, Nishith | Secretario | Tudor House 69 Camlet Way EN4 0NL Hadley Wood Hertfordshire | British | Accountant | 148459300001 | |||||
MELLER, Stephen Daniel | Secretario | 60 Wayside Avenue Bushey WD2 3SQ Watford Hertfordshire | British | 70938260002 | ||||||
CCS SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900001720001 | |||||||
BEAZER, Anthony Hadyn | Director | 172b West Hill Putney SW15 3SL London | United Kingdom | British | Director | 91412650001 | ||||
BROWN, Carole Elizabeth | Director | 11 Yelvertoft Road Crick NN6 7TR Northampton Barn 1 | England | British | Secretary | 98235420004 | ||||
BROWN, Keith Rodney | Director | Ambers Farm Kiln Road Hastoe HP23 6LT Tring Hertfordshire | British | Company Director | 30590760001 | |||||
CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | Director | 154997530001 | ||||
DIPRE, John Vivian | Director | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 9018280015 | ||||
DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | Director | 35117250001 | ||||
FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 69006050003 | ||||
FOSTER, David Martin | Director | Bear Park 31 Nightingale Road WD3 7DA Rickmansworth Hertfordshire | England | British | Chartered Town Planner | 50285750005 | ||||
GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | Director | 84605410002 | ||||
GANDHI, Devendra | Director | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | Director | 75350600002 | ||||
HIRSHMAN, Geoffrey Robin | Director | 3 Tanglewood Close Common Road HA7 3JA Stanmore Middlesex | England | British | Chartered Accountant | 34509080002 | ||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Cro | 137285750001 | ||||
MALDE, Nishith | Director | Tudor House 69 Camlet Way EN4 0NL Hadley Wood Hertfordshire | England | British | Accountant | 148459300001 | ||||
MORTIMORE, Jon William | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent | United Kingdom | British | Cfo | 207729000002 | ||||
WICKS, Stephen Desmond | Director | Sherwood House Oxhey Drive HA6 3EU Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 42298130002 | ||||
YULL, Peter Raymond | Director | Foxend Nugents Park Hatch End HA5 4RA Pinner Middlesex | British | Company Director | 12500120001 | |||||
CCS DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900001710001 |
¿Tiene ST JAMES VILLAGE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 09 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 28 abr 2005 Entregado el 11 may 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The property k/a jolly boatman, hampton court way, hampton court t/no SY354700. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 28 abr 2005 Entregado el 11 may 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 15 oct 2002 Entregado el 21 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 27 sept 2002 Entregado el 03 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The jolly boatman, hampton court way, hampton court, surrey t/n SY354700. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 31 ene 2002 Entregado el 02 feb 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £675,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Freehold property k/a the jolly boatman hampton court way hampton court surrey t/n SY354700. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 08 mar 1996 Entregado el 12 mar 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción First legal mortgage all that f/h property k/a land formerly forming part of hillview nursery at st james road goffs oak hertfordshire t/n's HD334870 and HD339207. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 28 feb 1996 Entregado el 29 feb 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a plums bunch st. James road goffs oak hertfordshire t/h HD209879. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0