ST JAMES VILLAGE LIMITED

ST JAMES VILLAGE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaST JAMES VILLAGE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02760151
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ST JAMES VILLAGE LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra ST JAMES VILLAGE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ST JAMES VILLAGE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BONCOURT LIMITED29 oct 199229 oct 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ST JAMES VILLAGE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ST JAMES VILLAGE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ST JAMES VILLAGE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016

    1 páginasAA01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Jonathan Ross Brodie el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP el 23 oct 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 oct 2015

    Estado de capital el 23 oct 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 15 dic 2014

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 oct 2014

    Estado de capital el 20 oct 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Elizabeth Catchpole como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Jon William Mortimore como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 oct 2013

    Estado de capital el 18 oct 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    13 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ST JAMES VILLAGE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Secretario
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147807730001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Director
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director62279790001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Director
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Director
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant194659450001
    FACER, John Leslie
    29 Bovingdon Green
    Bovingdon
    HP3 0LB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretario
    29 Bovingdon Green
    Bovingdon
    HP3 0LB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British33795700001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Secretario
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    BritishAccountant148459300001
    MELLER, Stephen Daniel
    60 Wayside Avenue
    Bushey
    WD2 3SQ Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    60 Wayside Avenue
    Bushey
    WD2 3SQ Watford
    Hertfordshire
    British70938260002
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Director
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritishDirector91412650001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    Director
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    EnglandBritishSecretary98235420004
    BROWN, Keith Rodney
    Ambers Farm
    Kiln Road Hastoe
    HP23 6LT Tring
    Hertfordshire
    Director
    Ambers Farm
    Kiln Road Hastoe
    HP23 6LT Tring
    Hertfordshire
    BritishCompany Director30590760001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154997530001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Director
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    FOSTER, David Martin
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Town Planner50285750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    HIRSHMAN, Geoffrey Robin
    3 Tanglewood Close
    Common Road
    HA7 3JA Stanmore
    Middlesex
    Director
    3 Tanglewood Close
    Common Road
    HA7 3JA Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountant34509080002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Director
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant148459300001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United KingdomBritishCfo207729000002
    WICKS, Stephen Desmond
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    Director
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director42298130002
    YULL, Peter Raymond
    Foxend Nugents Park
    Hatch End
    HA5 4RA Pinner
    Middlesex
    Director
    Foxend Nugents Park
    Hatch End
    HA5 4RA Pinner
    Middlesex
    BritishCompany Director12500120001
    CCS DIRECTORS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001710001

    ¿Tiene ST JAMES VILLAGE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 09 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 28 abr 2005
    Entregado el 11 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a jolly boatman, hampton court way, hampton court t/no SY354700. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 28 abr 2005
    Entregado el 11 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 15 oct 2002
    Entregado el 21 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 12 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 sept 2002
    Entregado el 03 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The jolly boatman, hampton court way, hampton court, surrey t/n SY354700. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 12 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 ene 2002
    Entregado el 02 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £675,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Freehold property k/a the jolly boatman hampton court way hampton court surrey t/n SY354700.
    Personas con derecho
    • Whitbread Group PLC
    Transacciones
    • 02 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 mar 1996
    Entregado el 12 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First legal mortgage all that f/h property k/a land formerly forming part of hillview nursery at st james road goffs oak hertfordshire t/n's HD334870 and HD339207. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Egt Finance Limited
    Transacciones
    • 12 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 11 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 feb 1996
    Entregado el 29 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a plums bunch st. James road goffs oak hertfordshire t/h HD209879. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Egt Finance Limited
    Transacciones
    • 29 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 11 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0