GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED

GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02762842
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KEEPEAGER LIMITED09 nov 199209 nov 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016

    1 páginasAA01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP el 23 oct 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 oct 2015

    Estado de capital el 23 oct 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    4 páginasMR04

    Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 15 dic 2014

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 oct 2014

    Estado de capital el 20 oct 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Elizabeth Catchpole como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Jon William Mortimore como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 oct 2013

    Estado de capital el 18 oct 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    9 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Secretario
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147807760001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Director
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Director
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    TAYLOR, David John
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    Secretario
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    British136521790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINSON, David Charles
    7 Blenheim Court
    Wellesley Road
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    Director
    7 Blenheim Court
    Wellesley Road
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    British35117370001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Director
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    Director
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    EnglandBritish98235420004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Director
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MARSHALL, Louis Daniel
    22 Abigail Crescent
    ME5 9DZ Walderslade
    Kent
    Director
    22 Abigail Crescent
    ME5 9DZ Walderslade
    Kent
    United KingdomBritish152847400001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United KingdomBritish207729000002
    NESBITT, Peter Victor
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    Director
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    British27564990001
    PEDLEY, Mark Jonathan
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    British112119110001
    WEST, William Samuel
    Jonel Highview Lane
    Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    Director
    Jonel Highview Lane
    Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    British35383900001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 09 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 jul 2000
    Entregado el 27 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 18 dic 1998
    Entregado el 23 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a pymore bridport in the county of dorset t/n DT202773, DT207080, DT229615 & DT207062. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    First party commercial legal charge
    Creado el 17 sept 1996
    Entregado el 20 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H little hamonds farm london road burgess hill east sussex t/no SX116439 fixed charge all buildings and other structures fixed charge asigns of goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 03 nov 1995
    Entregado el 08 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a moorfields mill lane south holmwood surrey t/n SY599533, allbuildings structures items plant and machinery, goodwill, rentals claims under insurance policies relating or fixed to the property, floating charge over unattached plant machinery chattels and goods in connection with the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Assignment of life policy
    Creado el 26 sept 1995
    Entregado el 11 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Lloyd's life policy no 551/N3AA079 together with all rights, title, interests and accreations thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 07 sept 1995
    Entregado el 20 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    58 maywater close sanderstead surrey t/no: TGL304052. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 18 ago 1995
    Entregado el 29 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land k/a 5 and 5A hawthorne place and 9 linden place epsom surrey t/n's SY643611,SY364122 and SY80306. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Life policy assignation
    Creado el 20 may 1994
    Entregado el 02 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Lloyds underwriters :cygnet life policy no.:risk no.N3AAO79 together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 07 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 07 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a santa tecla stanstead caterham surrey t/n SY399840. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0