AQUARIUS GROUP LIMITED

AQUARIUS GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAQUARIUS GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02764569
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AQUARIUS GROUP LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra AQUARIUS GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    West House, Kings Cross Road
    Halifax
    HX1 1EB West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AQUARIUS GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AQUARIUS GROUP PLC25 may 199525 may 1995
    DELHAMPOST LIMITED13 nov 199213 nov 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AQUARIUS GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AQUARIUS GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    23 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 dic 2011

    Estado de capital el 14 dic 2011

    • Capital: GBP 9,208,064.4
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 oct 2010. La liste des actionnaires a été modifiée

    14 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 26 oct 2009. La liste des actionnaires a été modifiée

    14 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    12 páginasAA

    legacy

    22 páginas363a

    Certificado de re-registro de Compañía Pública Limitada a Privada

    1 páginasCERT10

    Re-registro del Memorándum y Estatutos

    91 páginasMAR

    legacy

    1 páginas53

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de re-registro

    RES02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    14 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    8 páginas363s

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2007

    17 páginasAA

    legacy

    8 páginas363s

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2006

    17 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 19 dic 2005

    2 páginas1.3

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    6 páginas1.4

    ¿Quiénes son los directivos de AQUARIUS GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector40164810001
    GARTLAND, Deborah Louise
    Rawson Avenue
    HX3 0LR Halifax
    34
    West Yorkshire
    Director
    Rawson Avenue
    HX3 0LR Halifax
    34
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director131545080001
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector40164810001
    BARKER, James Edward
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Secretario
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British42890001
    BARKER, James Edward
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Secretario
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British42890001
    BATES, Mark Richard
    46 St Michaels Avenue
    Bramhall
    SK7 2PL Stockport
    Cheshire
    Secretario
    46 St Michaels Avenue
    Bramhall
    SK7 2PL Stockport
    Cheshire
    BritishDirector11869700002
    DYSON, Valerie
    Park House
    Chelford Road, Henbury
    SK11 9PG Macclesfield
    Cheshire
    Secretario
    Park House
    Chelford Road, Henbury
    SK11 9PG Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director Chartered Acc109044200001
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant40164810001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Secretario designado corporativo
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    BARKER, James Edward
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Director
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector42890001
    BATES, Mark Richard
    46 St Michaels Avenue
    Bramhall
    SK7 2PL Stockport
    Cheshire
    Director
    46 St Michaels Avenue
    Bramhall
    SK7 2PL Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector11869700002
    BOTTOMLEY, Alan Ingham
    Dormy Lodge 40 Kent Road
    HG1 2JJ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Dormy Lodge 40 Kent Road
    HG1 2JJ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor2670590001
    DYSON, Valerie
    Park House
    Chelford Road, Henbury
    SK11 9PG Macclesfield
    Cheshire
    Director
    Park House
    Chelford Road, Henbury
    SK11 9PG Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director Chartered Acc109044200001
    GARTLAND, Anthony
    Broad Carr House
    Broad Carr Lane
    HX4 9BS Holywell Green
    Halifax
    Director
    Broad Carr House
    Broad Carr Lane
    HX4 9BS Holywell Green
    Halifax
    United KingdomBritishDirector27652170001
    GARTLAND, Anthony
    Broad Carr House
    Broad Carr Lane
    HX4 9BS Holywell Green
    Halifax
    Director
    Broad Carr House
    Broad Carr Lane
    HX4 9BS Holywell Green
    Halifax
    United KingdomBritishDirector27652170001
    GILHAM, Clive Martin
    No 3 Birch House, The Alders
    Allerton Park Chapel
    LS1 4ND Allerton
    Leeds, West Yorkshire
    Director
    No 3 Birch House, The Alders
    Allerton Park Chapel
    LS1 4ND Allerton
    Leeds, West Yorkshire
    BritishDirector97163670001
    GREEN, Malcolm Reginald
    Ivy House Farm Newport Road
    Haughton
    ST18 9JH Stafford
    Director
    Ivy House Farm Newport Road
    Haughton
    ST18 9JH Stafford
    BritishCompany Director43982280002
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant40164810001
    JONES, Steven David
    8 Kendal Way
    CW2 5SA Chorlton
    Cheshire
    Director
    8 Kendal Way
    CW2 5SA Chorlton
    Cheshire
    UkBritishDirector105876770001
    LAWSON, Ian Bruce
    15 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    Yorkshire
    Director
    15 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    Yorkshire
    EnglandBritishDirector79170680001
    LUDDINGTON, Stephen John
    Frodsham The Drive
    CM21 9EP Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Director
    Frodsham The Drive
    CM21 9EP Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishChief Executive60256340001
    PARKINSON, John
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director10307790002
    POWERS, Glenn Patrick
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    Director
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    BritishDirector72486520001
    SAMOLS, Leonard Cecil
    6 Mornington
    Digswell
    AL6 0AY Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    6 Mornington
    Digswell
    AL6 0AY Welwyn
    Hertfordshire
    BritishCompany Director39387650001
    SMITH, Graham
    98 St James Road
    YO15 3NJ Bridlington
    East Yorkshire
    Director
    98 St James Road
    YO15 3NJ Bridlington
    East Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director12510200001
    TAVENER, Robin Frederick
    The Mill House
    Wonersh
    GU5 0QY Guildford
    Surrey
    Director
    The Mill House
    Wonersh
    GU5 0QY Guildford
    Surrey
    BritishDirector11428240001
    WHALLEY, Jeffrey
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    Director
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritishCompany Director1955430002
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Director designado corporativo
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    ¿Tiene AQUARIUS GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 28 feb 2003
    Entregado el 19 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The 2,601,478 cumulative redeemable preference shares of £1 each in airbath group PLC held by the mortgagor together with all dividends or other distributions declared made or paid and all shares stocks securities rights or properties accruing or offered or to be offered by way of rights bonus option or otherwise arising from or in respect of the shares.
    Personas con derecho
    • Gartland Whalley & Barker PLC
    Transacciones
    • 19 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Creado el 06 dic 2002
    Entregado el 20 dic 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All sums which shall be an amount equal to at least the aggregate of all sums drawn at any time under a working capital facility offered to the company together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of the charged account.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 dic 2002Registro de un cargo (395)
    Mortgage of shares
    Creado el 17 ago 2001
    Entregado el 01 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The mortgaged property (means the 2,850,00 7 1/2 cumulative preference shares of £1 each in the company held by the mortgagor) with the payment and discharge of the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 01 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over deposit
    Creado el 30 jul 2001
    Entregado el 08 ago 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due on any account whatsoever from pine design manufacturing limited to the chargee under the charge or in respect of the pine design liabilities as defined in the facility letter (all terms as defined)
    Breve descripción
    The deposit of £1,133,288.50 and all other sum in the security account number 65982932 re; aquarius group PLC for pine design manufacturing limited.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ago 2001Registro de un cargo (395)
    Charge over deposit
    Creado el 30 jul 2001
    Entregado el 08 ago 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due on any account whatsoever from the company to the chargee under the guaranteed loan note instrument and/or the counter indemnity and the charge
    Breve descripción
    The deposit of £1,133,288.50 and all other sums in the security account number 65982932 re; aquarius group PLC for pine design manufacturing limited.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ago 2001Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 27 jul 2001
    Entregado el 04 ago 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 ago 2001Registro de un cargo (395)
    Guarantee and debenture
    Creado el 19 dic 1996
    Entregado el 03 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 01 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene AQUARIUS GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 oct 2003Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    19 dic 2005Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John H Twizell
    Geoffrey Martin & Co
    St James'S House
    LS1 2SP 28 Park Place
    Leeds
    Profesional
    Geoffrey Martin & Co
    St James'S House
    LS1 2SP 28 Park Place
    Leeds
    Geoffrey Martin
    Geoffrey Martin & Co
    St James'S House
    LS1 2SP 28 Park Place
    Leeds
    Profesional
    Geoffrey Martin & Co
    St James'S House
    LS1 2SP 28 Park Place
    Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0