MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02767051 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | The Akzonobel Building Wexham Road SL2 5DS Slough United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| IMPKEMIX (NO. 43) LIMITED | 23 nov 1992 | 23 nov 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 13 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 27 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 13 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Vaibhav Ahuja como director el 21 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Upton como director el 05 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr David Upton como director el 22 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Smalley como director el 07 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Benjamin Williams como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 18 páginas | AA | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 18 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de David Allan Turner como director el 01 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Benjamin Williams como director el 01 sept 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 may 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de David Allan Turner como director el 31 ago 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Fergal Joseph O'shea como director el 31 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 18 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Lynette Jean Cherryl Carter como secretario el 31 may 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
¿Quiénes son los directivos de MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUJA, Vaibhav, Mr. | Director | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | England | Indian | 327784660001 | |||||
| RAY, Stephen Bruce | Director | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | England | British | 177266980002 | |||||
| CARTER, Lynette Jean Cherryl | Secretario | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | 232329760001 | |||||||
| CHEATLE, Penelope Anne | Secretario | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | 34645590001 | ||||||
| DAVIS, Philip Stephen James | Secretario | Two Pearman Cottages 29 Chertsey Road GU24 8PD Chobham Surrey | British | 71932630001 | ||||||
| GROSSET, Margaret Wilhelmina | Secretario | 7 Arnprior Place KA7 4PT Alloway Ayrshire | British | 54009620001 | ||||||
| GROSSET, Margaret Wilhelmina | Secretario | 7 Arnprior Place KA7 4PT Alloway Ayrshire | British | 54009620001 | ||||||
| LACHLAN, Cacilia Maria | Secretario designado | 10 Guernsey Farm Drive Horsell Rise GU21 4BE Woking Surrey | British | 900008880001 | ||||||
| MCCARTHY, Anne Patricia | Secretario | 46 Torcross Road HA4 0TD South Ruislip Middlesex | British | 8702280009 | ||||||
| SPARKS, Raymond Richard | Secretario | 19 Queens Road Byfleet KT14 7AD West Byfleet Surrey | British | 35662370002 | ||||||
| THORN-DAVIS, Scott Peter | Secretario | 5 Latham Road TW1 1BN Twickenham Middlesex | British | 68718610003 | ||||||
| TURNER, George St John | Secretario | The Manse Main Street PE28 0QR Bythorn Cambridgeshire | British | 88865090002 | ||||||
| O.H. SECRETARIAT LIMITED | Secretario corporativo | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | 129226660002 | |||||||
| BLACKWOOD, David Charles | Director | 7 Mizen Close KT11 2RJ Cobham Surrey | United Kingdom | British, | 69535430001 | |||||
| BLOK, Harm | Director | Bressenden Place SW1E 5BG London 26th Floor Portland House | The Netherlands | Dutch | 176466280001 | |||||
| BOLLAND, Christopher | Director | Bressenden Place SW1E 5BG London 26th Floor Portland House | United Kingdom | British | 111301880002 | |||||
| BOURNE, Anthony John, Dr | Director | 138 Cambridge Street SW1V 4QF London | England | British | 12074490001 | |||||
| CHANDLER, Allan Illingworth | Director | 95 Silverdale Avenue KT12 1EJ Walton On Thames Surrey | British | 73841170001 | ||||||
| CHARLTON, John Michael | Director | Dunstone 5 Broomfield Ride KT22 0LR Oxshott Surrey | England | British | 73081460001 | |||||
| CHEATLE, Penelope Anne | Director | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | 34645590001 | ||||||
| CHEATLE, Penelope Anne | Director | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | 34645590001 | ||||||
| CRIBB, Nigel Rupert Evelyn | Director | 7 White Friars TN13 1QG Sevenoaks Kent | England | British | 77813530002 | |||||
| GEE, David John | Director | Manchester Square W1U 3AN London 20 | England | British | 43451240003 | |||||
| GILLETT, Philip John | Director | Cedar House Rockfield Road RH8 0EJ Oxted Surrey | United Kingdom | British | 6838010001 | |||||
| GRAY, Frederick Philp | Director | Torran 22 The Ridings KT24 5BN East Horsley Surrey | England | British | 11184160001 | |||||
| HERLIHY, Michael Hugh Creedon | Director | Greensands Pine Grove PO19 3PN Chichester West Sussex England | United Kingdom | British | 34548990001 | |||||
| HIRST, John Raymond | Director | 53b Windsor Road SL6 2DN Maidenhead Buckinghamshire | British | 59246220001 | ||||||
| LACHLAN, Cacilia Maria | Director designado | 10 Guernsey Farm Drive Horsell Rise GU21 4BE Woking Surrey | British | 900008880001 | ||||||
| LADD, Ian Richard | Director | Flat 4, 22 Greencroft Gardens NW6 3LS London | British | 42846300002 | ||||||
| O'SHEA, Fergal Joseph | Director | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | United Kingdom | Irish | 202596380001 | |||||
| RADDER, Helmut Kurt Hans | Director | Flat F 11 Queens Gate Terrace SW7 5PR London | German | 73769570001 | ||||||
| REVILL, Ian | Director | 11 Kevan Drive Send GU23 7BU Woking Surrey | United Kingdom | British | 33088030001 | |||||
| ROSS, Robert Leonard Gordon Knox | Director | Bressenden Place SW1E 5BG London 26th Floor Portland House | United Kingdom | British | 103698440001 | |||||
| SEARLES, David Arthur | Director | Oak Tree Cottage Tower Road Coleshill HP7 0LB Amersham Buckinghamshire | British | 40322970002 | ||||||
| SINGH, Brune | Director | Floor Portland House Bressenden Place SW1E 5BG London 26th United Kingdom | Netherlands | British | 135902980002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergon Investments Uk Limited | 20 may 2016 | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0