KIRKHEATON WIND LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KIRKHEATON WIND LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02771937 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KIRKHEATON WIND LIMITED?
- Producción de electricidad (35110) / Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
¿Dónde se encuentra KIRKHEATON WIND LIMITED?
| Dirección de la sede social | Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland England England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KIRKHEATON WIND LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| UK GAS & ELECTRIC LIMITED | 21 ene 1993 | 21 ene 1993 |
| KILDALE LIMITED | 08 dic 1992 | 08 dic 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KIRKHEATON WIND LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KIRKHEATON WIND LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ian Jessop como director el 01 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Estado de capital el 03 jul 2023
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Laura Katherine Chare como secretario el 24 nov 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Melanie Shanker como secretario el 24 nov 2022 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Piero Maggio como director el 16 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Pierre-Arthur, Maurice, Michel Lestrade como director el 16 may 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Pierre-Arthur, Maurice, Michel Lestrade como director el 22 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthieu Thomas Hue como director el 22 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Susan Elizabeth Lind como secretario el 23 nov 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Laura Katherine Chare como secretario el 23 nov 2020 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 29 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KIRKHEATON WIND LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANKER, Melanie | Secretario | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | 303067320001 | |||||||
| JESSOP, Ian | Director | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | Scotland | British | 312208460001 | |||||
| MAGGIO, Piero | Director | 1 Mandarin Road, Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England | England | British | 296324960001 | |||||
| MAJID, Hassaan | Director | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | England | British | 227170770002 | |||||
| CHARE, Laura Katherine | Secretario | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | 280497220001 | |||||||
| ELLIOTT, John | Secretario | 18 Frosterley Drive DH3 4SJ Great Lumley County Durham | British | 157550030001 | ||||||
| GILES, Gail Valerie | Secretario | North Sundaysight Bellingham NE48 2JE Hexham Northumberland | British | 108926390001 | ||||||
| HIGSON, Robert Ian | Secretario | Springfield Calvert Road RH4 1LT Dorking Surrey | British | 61249910002 | ||||||
| KACZOROWSKI, Stephane | Secretario | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 England England | 187107410001 | |||||||
| LIND, Susan Elizabeth | Secretario | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | 200530650001 | |||||||
| SOUTO, Joe | Secretario | 40 Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London | 146431380001 | |||||||
| DICKINSON DEES | Secretario designado corporativo | St Anns Wharf 112 Quayside NE99 1SB Newcastle Upon Tyne | 900005460001 | |||||||
| ANCEAU, Geraldine Marie Roseline | Director | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 England England | France | French | 220722130001 | |||||
| BAKER, David Simon George | Director | 40 Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London | United Kingdom | British | 197462530001 | |||||
| CARE, Timothy James | Director designado | West House Whorlton Hall Farm Westerhope NE5 1NP Newcastle Upon Tyne | British | 900005450001 | ||||||
| CHANDLER, Malcolm George | Director | 40 Earnshaw Way Beaumont Park NE25 9UN Whitley Bay Tyne & Wear | British | 32594940001 | ||||||
| CONNOR, Phillip Eric | Director | Billy Hill House Stanley DL15 9QS Crook County Durham | England | English | 72946860001 | |||||
| CUTTILL, Paul Andrew | Director | 25 Bushey Avenue South Woodford E18 2DT London | British | 116268290001 | ||||||
| DANIELS, Christopher John | Director | Mistletoe Cottage 57 Wickham Hill BN6 9NR Hurstpierpoint West Sussex | British | 72808850001 | ||||||
| DIXON, Adrian | Director | 155 Norwich Road Wroxham NR12 8RZ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 125881320001 | |||||
| FORSTER, Owen John Henry | Director | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | England | British | 208859480001 | |||||
| FORSTER, Owen John Henry | Director | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | England | British | 208859480001 | |||||
| GUYLER, Robert | Director | 40 Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London | Scotland | British | 183996210001 | |||||
| HUE, Matthieu Thomas | Director | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | England | French | 183883770001 | |||||
| LARSEN, Bruno Kold | Director | 40 Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London | Denmark | Danish | 178861250001 | |||||
| LAWLESS, Philip Stewart, Dr | Director | Old Courthouse Kirkwhelpington NE19 2RS Newcastle Upon Tyne | England | British | 92885220001 | |||||
| LAWRENCE, Martin Charles | Director | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | England | British | 121114690001 | |||||
| LESTRADE, Pierre-Arthur, Maurice, Michel | Director | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | Greece | French | 276922120001 | |||||
| LINGE, Kenneth | Director | Drystones Heugh House Lane NE47 6ND Haydon Bridge Northumberland | England | British | 52698930001 | |||||
| LORY, Ronan Emmanuel | Director | 40 Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London | United Kingdom | French | 163104520001 | |||||
| NORMAN, Angus Tindale | Director | 11 Granville Road Walmer CT14 7LU Deal Kent | British | 80532370001 | ||||||
| STILL, David John | Director | Redpath Haltwhistle NE49 0LG Northumberland Ivy Cottage England England | United Kingdom | British | 9482280007 | |||||
| TAYLOR, Richard Charles | Director | 3 King Edwards Court Front Street Tynemouth NE30 4DZ North Shields Tyne & Wear | British | 69207290003 | ||||||
| VERDI, Joseph | Director | Fairlight Cottage Off Holtye Road RH19 3QF East Grinstead West Sussex | British | 103102930001 | ||||||
| WINGROVE, Gerald Langdon | Director | 96 Albert Street NW1 7NE London | United Kingdom | British | 34815220001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KIRKHEATON WIND LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edf Energy Renewables Holdings Limited | 06 abr 2016 | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0