KIRKHEATON WIND LIMITED

KIRKHEATON WIND LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKIRKHEATON WIND LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02771937
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KIRKHEATON WIND LIMITED?

    • Producción de electricidad (35110) / Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

    ¿Dónde se encuentra KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Alexander House 1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    England
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    UK GAS & ELECTRIC LIMITED21 ene 199321 ene 1993
    KILDALE LIMITED08 dic 199208 dic 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Mr Ian Jessop como director el 01 ago 2023

    2 páginasAP01

    Estado de capital el 03 jul 2023

    • Capital: GBP 257
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 15 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Laura Katherine Chare como secretario el 24 nov 2022

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Ms Melanie Shanker como secretario el 24 nov 2022

    2 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    32 páginasAA

    Nombramiento de Mr Piero Maggio como director el 16 may 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Pierre-Arthur, Maurice, Michel Lestrade como director el 16 may 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 15 may 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Pierre-Arthur, Maurice, Michel Lestrade como director el 22 dic 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Matthieu Thomas Hue como director el 22 dic 2021

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    33 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Susan Elizabeth Lind como secretario el 23 nov 2020

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Laura Katherine Chare como secretario el 23 nov 2020

    2 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    31 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    29 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHANKER, Melanie
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Secretario
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    303067320001
    JESSOP, Ian
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Director
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    ScotlandBritish312208460001
    MAGGIO, Piero
    1 Mandarin Road, Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    Director
    1 Mandarin Road, Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    EnglandBritish296324960001
    MAJID, Hassaan
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Director
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    EnglandBritish227170770002
    CHARE, Laura Katherine
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Secretario
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    280497220001
    ELLIOTT, John
    18 Frosterley Drive
    DH3 4SJ Great Lumley
    County Durham
    Secretario
    18 Frosterley Drive
    DH3 4SJ Great Lumley
    County Durham
    British157550030001
    GILES, Gail Valerie
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    Secretario
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    British108926390001
    HIGSON, Robert Ian
    Springfield
    Calvert Road
    RH4 1LT Dorking
    Surrey
    Secretario
    Springfield
    Calvert Road
    RH4 1LT Dorking
    Surrey
    British61249910002
    KACZOROWSKI, Stephane
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    Secretario
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    187107410001
    LIND, Susan Elizabeth
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Secretario
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    200530650001
    SOUTO, Joe
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    Secretario
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    146431380001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Secretario designado corporativo
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    ANCEAU, Geraldine Marie Roseline
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    Director
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    FranceFrench220722130001
    BAKER, David Simon George
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    Director
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    United KingdomBritish197462530001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Director designado
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    CHANDLER, Malcolm George
    40 Earnshaw Way
    Beaumont Park
    NE25 9UN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Director
    40 Earnshaw Way
    Beaumont Park
    NE25 9UN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British32594940001
    CONNOR, Phillip Eric
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    Director
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    EnglandEnglish72946860001
    CUTTILL, Paul Andrew
    25 Bushey Avenue
    South Woodford
    E18 2DT London
    Director
    25 Bushey Avenue
    South Woodford
    E18 2DT London
    British116268290001
    DANIELS, Christopher John
    Mistletoe Cottage
    57 Wickham Hill
    BN6 9NR Hurstpierpoint
    West Sussex
    Director
    Mistletoe Cottage
    57 Wickham Hill
    BN6 9NR Hurstpierpoint
    West Sussex
    British72808850001
    DIXON, Adrian
    155 Norwich Road
    Wroxham
    NR12 8RZ Norwich
    Norfolk
    Director
    155 Norwich Road
    Wroxham
    NR12 8RZ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish125881320001
    FORSTER, Owen John Henry
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Director
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    EnglandBritish208859480001
    FORSTER, Owen John Henry
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Director
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    EnglandBritish208859480001
    GUYLER, Robert
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    Director
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    ScotlandBritish183996210001
    HUE, Matthieu Thomas
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Director
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    EnglandFrench183883770001
    LARSEN, Bruno Kold
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    Director
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    DenmarkDanish178861250001
    LAWLESS, Philip Stewart, Dr
    Old Courthouse
    Kirkwhelpington
    NE19 2RS Newcastle Upon Tyne
    Director
    Old Courthouse
    Kirkwhelpington
    NE19 2RS Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish92885220001
    LAWRENCE, Martin Charles
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Director
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    EnglandBritish121114690001
    LESTRADE, Pierre-Arthur, Maurice, Michel
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Director
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    GreeceFrench276922120001
    LINGE, Kenneth
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    Director
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    EnglandBritish52698930001
    LORY, Ronan Emmanuel
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    Director
    40 Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    United KingdomFrench163104520001
    NORMAN, Angus Tindale
    11 Granville Road
    Walmer
    CT14 7LU Deal
    Kent
    Director
    11 Granville Road
    Walmer
    CT14 7LU Deal
    Kent
    British80532370001
    STILL, David John
    Redpath
    Haltwhistle
    NE49 0LG Northumberland
    Ivy Cottage
    England
    England
    Director
    Redpath
    Haltwhistle
    NE49 0LG Northumberland
    Ivy Cottage
    England
    England
    United KingdomBritish9482280007
    TAYLOR, Richard Charles
    3 King Edwards Court Front Street
    Tynemouth
    NE30 4DZ North Shields
    Tyne & Wear
    Director
    3 King Edwards Court Front Street
    Tynemouth
    NE30 4DZ North Shields
    Tyne & Wear
    British69207290003
    VERDI, Joseph
    Fairlight Cottage
    Off Holtye Road
    RH19 3QF East Grinstead
    West Sussex
    Director
    Fairlight Cottage
    Off Holtye Road
    RH19 3QF East Grinstead
    West Sussex
    British103102930001
    WINGROVE, Gerald Langdon
    96 Albert Street
    NW1 7NE London
    Director
    96 Albert Street
    NW1 7NE London
    United KingdomBritish34815220001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KIRKHEATON WIND LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    06 abr 2016
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06658187
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0