INTERCAPITAL NO. 2 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INTERCAPITAL NO. 2 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02774629 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INTERCAPITAL NO. 2 LIMITED?
- Otras actividades de apoyo al transporte (52290) / Transporte y almacenamiento
¿Dónde se encuentra INTERCAPITAL NO. 2 LIMITED?
| Dirección de la sede social | London Fruit And Wool Exchange 1 Duval Square E1 6PW London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTERCAPITAL NO. 2 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ICAP SHIPPING TANKERS LIMITED | 31 jul 2008 | 31 jul 2008 |
| CAPITAL SHIPBROKERS LIMITED | 31 mar 2006 | 31 mar 2006 |
| CAPITAL SHIPBROKERS (UK) LIMITED | 27 mar 2006 | 27 mar 2006 |
| CAPITAL SHIPBROKERS LIMITED | 26 ene 1993 | 26 ene 1993 |
| SPEED 3188 LIMITED | 17 dic 1992 | 17 dic 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERCAPITAL NO. 2 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERCAPITAL NO. 2 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 07 sept 2022
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kathleen Marie Cronin como director el 11 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Margaret Austin Wright como secretario el 08 jul 2021 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Jenelle Marie Chalmers como secretario el 08 jul 2021 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Veronica Holly Ridley como secretario el 01 jul 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Richard Joseph Bodnum el 02 nov 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de James Bray como director el 12 abr 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Frederick Knottenbelt como director el 12 abr 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Intercapital Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov 2020 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Intercapital No. 1 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Veronica Holly Ridley como secretario el 14 ene 2020 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Deborah Anne Abrehart como secretario el 31 dic 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INTERCAPITAL NO. 2 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHALMERS, Jenelle Marie | Secretario | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | 285199790001 | |||||||
| WRIGHT, Margaret Austin | Secretario | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | 285199900001 | |||||||
| BODNUM, Richard Joseph | Director | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | United States | American | 261217990002 | |||||
| BRAY, James | Director | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | England | British | 281148420001 | |||||
| SEAMAN, Adrienne Hilary | Director | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | England | British | 260951030001 | |||||
| ABREHART, Deborah Anne | Secretario | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | 230114360001 | |||||||
| CAVANAGH, Teri-Anne | Secretario | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | South African | 98738710014 | ||||||
| METCALFE, John Timothy | Secretario | Swallowfield Pollards Wood Hill Limpsfield RH8 0QX Oxted Surrey | British | 32612740001 | ||||||
| RIDLEY, Veronica Holly | Secretario | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | 266434220001 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| ACHESON-GRAY, Giles Henry | Director | Bardleden Manor Biddenden Road TN27 8QG Smarden Kent | British | 27247330003 | ||||||
| BARCLAY, Lorraine Emma | Director | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | England | British | 156498490001 | |||||
| CASTERTON, David Anthony | Director | Broadgate EC2M 7UR London 2 | United Kingdom | British | 221477890001 | |||||
| COMBE, Michael Percy | Director | The Thatched House Emery Down SO43 7EB Lyndhurst Hampshire | England | British | 34376190001 | |||||
| COMBE, Michael Percy | Director | The Thatched House Emery Down SO43 7EB Lyndhurst Hampshire | England | British | 34376190001 | |||||
| CRONIN, Kathleen Marie | Director | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | United States | American | 156507760001 | |||||
| DARGAN, Nicholas James | Director | Broadgate EC2M 7UR London 2 | England | British | 298810620001 | |||||
| FYFE, Alan Giles | Director | Blandings Merle Common RH8 0RP Oxted Surrey | British | 27247350001 | ||||||
| GORDON CLARK, Edmund Francis | Director | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | United Kingdom | British | 106715260001 | |||||
| HACKING, Stephen David | Director | 95 Drakefield Road SW17 8RS London | British | 34376210005 | ||||||
| HARRISON, Simon Nicholas Ian | Director | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | England | British | 59864540003 | |||||
| JACKSON, Nicholas David | Director | 101 Ashley Gardens Thirleby Road SW1P 1HJ London | British | 2587350005 | ||||||
| JUNCHER, Jacob | Director | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | Danish | 93424280001 | ||||||
| KIDD, Timothy Charles | Director | Broadgate EC2M 7UR London 2 | England | British | 117842820001 | |||||
| KNOTTENBELT, William Frederick | Director | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | United Kingdom | British | 133292870001 | |||||
| LIDDELL, Henry Grainger | Director | Broadgate EC2M 7UR London 2 | United Kingdom | British | 34376200006 | |||||
| LIDDELL, Henry Grainger | Director | Lambridge Wood House Bix RG9 4RZ Henley On Thames Oxfordshire | England | British | 34376200004 | |||||
| MACPHERSON, James Grant | Director | 10 Grosvenor Avenue East Sheen SW14 8BX London | British | 104039980001 | ||||||
| MAYHEW, Lucy Rachel | Director | Broadgate EC2M 7UR London 2 | England | British | 151929170002 | |||||
| MCCOWEN, Michael Ewan | Director | 103 Winchester Street Pimlico SW1V 4NX London | England | British | 104039890003 | |||||
| METCALFE, John Timothy | Director | Swallowfield Pollards Wood Hill Limpsfield RH8 0QX Oxted Surrey | British | 32612740001 | ||||||
| NEWMAN, Paul | Director | Broadgate EC2M 7UR London 2 | England | British | 213629960001 | |||||
| NEWMAN, Paul | Director | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | England | British | 213629960001 | |||||
| PARSBO, Christian Heerdegen | Director | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | Danish | 121505700001 | ||||||
| WILLIAMSON, David Alexander | Director | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | England | British | 250208690001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INTERCAPITAL NO. 2 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercapital Limited | 11 nov 2020 | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Intercapital No. 1 Limited | 06 abr 2016 | 1 Duval Square E1 6PW London London Fruit And Wool Exchange England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene INTERCAPITAL NO. 2 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creado el 05 oct 2001 Entregado el 10 oct 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H flat 3 gladstone court regency street london SW1P 4AL t/no.NGL602673. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture deed | Creado el 30 abr 1997 Entregado el 09 may 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 24 mar 1993 Entregado el 27 mar 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date | |
Breve descripción The sum of £23,000 held in the interest-bearing account opened by the landlord. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0