365 IT SUBCO NO.2 LIMITED

365 IT SUBCO NO.2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresa365 IT SUBCO NO.2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02776263
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de 365 IT SUBCO NO.2 LIMITED?

    • Actividades de consultoría en tecnología de la información (62020) / Información y comunicación
    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra 365 IT SUBCO NO.2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Napoleon House Riseley Business Park, Basingstoke Road
    Riseley
    RG7 1NW Reading
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de 365 IT SUBCO NO.2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DYNAX SYSTEMS LIMITED01 mar 199301 mar 1993
    DELTASYS LIMITED23 dic 199223 dic 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de 365 IT SUBCO NO.2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para 365 IT SUBCO NO.2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de 4 Cartel Business Centre Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW United Kingdom el 10 abr 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 23 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 feb 2012

    Estado de capital el 01 feb 2012

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Nombramiento de Mr Peter Hugh Howells como director el 22 sept 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Peter Maclean como director el 22 sept 2011

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 24 nov 2011

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    3 páginasCONNOT

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Approve transfer of cap 22/09/2011
    RES13

    legacy

    3 páginasMG02

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2010 au 30 jun 2011

    1 páginasAA01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 4 Cartel Business Centre Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW United Kingdom

    1 páginasAD02

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Nombramiento de Mb Secretaries Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Déclaration annuelle établie au 23 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Alastair Ferguson como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Alastair Ferguson como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    14 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Hearn como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Alastair William Ferguson como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de David Hearn como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Alastair William Ferguson como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 23 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de 365 IT SUBCO NO.2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MB SECRETARIES LIMITED
    The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4813248
    124285230001
    ALEJOS, Eduardo
    Riseley Business Park, Basingstoke Road
    Riseley
    RG7 1NW Reading
    Napoleon House
    England
    Director
    Riseley Business Park, Basingstoke Road
    Riseley
    RG7 1NW Reading
    Napoleon House
    England
    United KingdomSpanishComputer Engineer127120140001
    HOWELLS, Peter Hugh
    11 Romans Field
    Silchester
    RG7 2QH Reading
    Centurion House
    Uk
    England
    Director
    11 Romans Field
    Silchester
    RG7 2QH Reading
    Centurion House
    Uk
    England
    EnglandBritishDirector163030330001
    FERGUSON, Alastair William
    Cartel Business Centre
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    Cartel Business Centre
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4
    Hampshire
    United Kingdom
    154526470001
    HEARN, David Gareth
    Cartel Business Centre
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    Cartel Business Centre
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4
    Hampshire
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant59462210001
    TURNER, Alan George
    2 Whitehead Close
    Lychpit
    RG24 8SG Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    2 Whitehead Close
    Lychpit
    RG24 8SG Basingstoke
    Hampshire
    British32049970001
    TURNER, Linda Elizabeth
    2 Whitehead Close
    Lychpit
    RG24 8SG Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    2 Whitehead Close
    Lychpit
    RG24 8SG Basingstoke
    Hampshire
    BritishSecretary32049960001
    TURNER, Linda Elizabeth
    2 Whitehead Close
    Lychpit
    RG24 8SG Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    2 Whitehead Close
    Lychpit
    RG24 8SG Basingstoke
    Hampshire
    British32049960001
    MB SECRETARIES LIMITED
    11 The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    Hampshire
    Secretario corporativo
    11 The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    Hampshire
    124285230001
    SEYMOUR MACINTYRE LIMITED
    51 Quarry Street
    GU1 3UA Guildford
    Surrey
    Secretario corporativo
    51 Quarry Street
    GU1 3UA Guildford
    Surrey
    1363280001
    FERGUSON, Alastair William
    Cartel Business Centre
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Cartel Business Centre
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant125179970001
    HEARN, David Gareth
    Cartel Business Centre
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Cartel Business Centre
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant59462210001
    MACLEAN, Peter
    Steventon Manor
    RG25 3BE Steventon
    Hampshire
    Director
    Steventon Manor
    RG25 3BE Steventon
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector157773140001
    TURNER, Alan George
    2 Whitehead Close
    Lychpit
    RG24 8SG Basingstoke
    Hampshire
    Director
    2 Whitehead Close
    Lychpit
    RG24 8SG Basingstoke
    Hampshire
    BritishConsultant Engineer32049970001

    ¿Tiene 365 IT SUBCO NO.2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 31 jul 2009
    Entregado el 15 ago 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 15 ago 2009Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 09 abr 2009
    Entregado el 21 abr 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 abr 2009Registro de un cargo (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 03 nov 2008
    Entregado el 12 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 12 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 11 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    All assets debenture
    Creado el 07 feb 2008
    Entregado el 09 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limtied
    Transacciones
    • 09 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 09 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 24 nov 1997
    Entregado el 02 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage unit 4 cartel business centre, wade road, basingstoke, hampshire all covenants and rights affecting or concerning the property and any share from time to time held by the company in any landlord or management company of the property. By way of fixed charge the plant, machinery and fixtures and fittings, furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels, goodwill of any business and the proceeds of any insurance.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 22 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0