YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED

YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaYELLOW DOOR PROPERTY LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02779638
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    10 Wythburn Court Seymour Place
    W1H 7NS London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    YELLOW DOOR PROPERTY COMPANY LIMITED14 ene 199314 ene 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2025
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta03 may 2025
    Próxima declaración de confirmación vence17 may 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta03 may 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Mr Paul Martyn Ashley en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 sept 2021

    2 páginasPSC04

    Declaración de confirmación presentada el 03 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    10 páginasAA

    Registro de la carga 027796380032, creada el 03 abr 2023

    23 páginasMR01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022

    11 páginasAA

    Registro de la carga 027796380031, creada el 16 ago 2022

    5 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 03 may 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 29 mar 2022

    • Capital: GBP 1,205
    3 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 27 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021

    12 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 sept 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Registro de la carga 027796380030, creada el 05 feb 2021

    4 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 027796380029

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 027796380028

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Compra de acciones propias.

    3 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    08 sept 2020Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Cese del nombramiento de Mark Andrew Peters como director el 03 abr 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    13 páginasAA

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 15 feb 2020

    • Capital: GBP 1.175
    6 páginasSH06

    Registro de la carga 027796380029, creada el 04 feb 2020

    29 páginasMR01

    Registro de la carga 027796380028, creada el 04 feb 2020

    28 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ASHLEY, Paul Martyn
    Seymour Place
    W1H 7NS London
    10 Wythburn Court
    England
    Director
    Seymour Place
    W1H 7NS London
    10 Wythburn Court
    England
    EnglandBritishCompany Director35065720001
    JOSEPH, Steven Falcon
    Gloucester Avenue
    NW1 8LB London
    113
    England
    Director
    Gloucester Avenue
    NW1 8LB London
    113
    England
    United KingdomBritishCompany Director130124020002
    ASHLEY, Joanne
    Argyll Street
    W1F 7LD London
    Palladium House
    England
    Secretario
    Argyll Street
    W1F 7LD London
    Palladium House
    England
    BritishOffice Manager110013440001
    HOOD, James Walter
    Wythburn Court 34 Seymour Place
    W1H 7NS London
    Secretario
    Wythburn Court 34 Seymour Place
    W1H 7NS London
    British55078250001
    HUGHES, William Edwin Charles
    31 Cumberland Close
    HP21 7HH Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    31 Cumberland Close
    HP21 7HH Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishAccountant11605390001
    SHAH, Vimal
    9 Southfield Road
    W4 1AG Chiswick
    London
    Secretario designado
    9 Southfield Road
    W4 1AG Chiswick
    London
    British900004180001
    ASHLEY, Joanne
    Argyll Street
    W1F 7LD London
    Palladium House
    England
    Director
    Argyll Street
    W1F 7LD London
    Palladium House
    England
    United KingdomBritishOffice Manager110013440001
    CHOWDHARY, Balvinder Kaur
    112 Park Road
    TW12 1HR Hampton Hill
    Middlesex
    England
    Director designado
    112 Park Road
    TW12 1HR Hampton Hill
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish900004170001
    HUGHES, William Edwin Charles
    31 Cumberland Close
    HP21 7HH Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    31 Cumberland Close
    HP21 7HH Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishAccountant11605390001
    KING, Vernon
    68 Gubbins Lane
    Harold Wood
    RM3 0BL Romford
    Essex
    Director
    68 Gubbins Lane
    Harold Wood
    RM3 0BL Romford
    Essex
    BritishMarketing18650000001
    LAMONT, Barclay William
    8 Manor Crescent
    KT5 8LQ Surbiton
    Surrey
    Director
    8 Manor Crescent
    KT5 8LQ Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director1606720001
    PETERS, Mark Andrew
    c/o Sherrards Solicitors
    Grosvenor Road
    AL1 3AW St. Albans
    45
    Hertfordshire
    England
    Director
    c/o Sherrards Solicitors
    Grosvenor Road
    AL1 3AW St. Albans
    45
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishSolicitor137074310003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Paul Martyn Ashley
    Seymour Place
    W1H 7NS London
    Wythburn Court
    England
    14 abr 2016
    Seymour Place
    W1H 7NS London
    Wythburn Court
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene YELLOW DOOR PROPERTY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 03 abr 2023
    Entregado el 06 abr 2023
    Pendiente
    Breve descripción
    The hall, hall drive, lakenheath IP27 9JT.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 06 abr 2023Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 16 ago 2022
    Entregado el 17 ago 2022
    Pendiente
    Breve descripción
    Land adjoining 1 the dell london SE19 2QA.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • Jonathan David Moore and Rebecca Clare Burridge
    Transacciones
    • 17 ago 2022Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 05 feb 2021
    Entregado el 22 feb 2021
    Pendiente
    Breve descripción
    As a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities, the mortgagor with full title guarantee charges to the lender a first legal mortgage over land at flat 10B 10 queens gardens bayswater W2 3BA as registered under title NGL682990 and a first fixed charge. For more details please refer to the instrument.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • Keystone Property Finance Limited
    Transacciones
    • 22 feb 2021Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 04 feb 2020
    Entregado el 12 feb 2020
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    All that leasehold interest in the land and property known as flat 10B, 10 queens gardens, bayswater (W2 3BA) and registered at the land registry with title absolute under title number NGL682990.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Interbay Funding Limited
    Transacciones
    • 12 feb 2020Registro de una carga (MR01)
    • 15 feb 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 04 feb 2020
    Entregado el 12 feb 2020
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    All that leasehold interest in the land and property known as flat 10B, 10 queens gardens, bayswater (W2 3BA) and registered at the land registry with title absolute under title number NGL682990.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Interbay Funding Limited
    Transacciones
    • 12 feb 2020Registro de una carga (MR01)
    • 15 feb 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 04 ene 2017
    Entregado el 06 ene 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Land at hailes street winchcombe GL54 5HU registered at the land registry under title number GR377249.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • Alma Lilian Ashley
    Transacciones
    • 06 ene 2017Registro de una carga (MR01)
    • 27 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 03 nov 2016
    Entregado el 07 nov 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all legal interest in perivale methodist church site may gardens wembley HA0 1DT land registry no. MX394732 and AGL389948.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 nov 2016Registro de una carga (MR01)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 31 ago 2016
    Entregado el 31 ago 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all legal interest in plots 10 and 18 gentle rise lakenheath suffolk IP27 9NB (land registry title nos: SK365470 and SK365609).
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 31 ago 2016Registro de una carga (MR01)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 02 jun 2016
    Entregado el 02 jun 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all legal interest in plots 1-3 over road (previously known as 3 whites path and surrounding land) willingham cambridgeshire CB24 5ET (land registry title nos: CB141791 CB146375 CB258258 CB268697 and CB388303).
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 jun 2016Registro de una carga (MR01)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 10 may 2016
    Entregado el 17 may 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 may 2016Registro de una carga (MR01)
    • 27 nov 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 02 dic 2015
    Entregado el 03 dic 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Freehold property known as 10 over road, willingham, cambridge, CB24 5EU being all of the land and buildings in title CB161579 including all buildings, fixtures and fittings, the related rights and the goodwill.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Shawbrook Bank Limited
    Transacciones
    • 03 dic 2015Registro de una carga (MR01)
    • 22 feb 2016Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    • 04 jun 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 02 feb 2010
    Entregado el 04 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    37 oakwood road wimbledon london t/nos. SGL44657 and SGL445689 by way of fixed charge any other interest in the property all rents receivable from any lease granted out of the property and the proceeds of any insurance affecting the property.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 28 ene 2010
    Entregado el 02 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 ene 2008
    Entregado el 06 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land to the rear of 17 st johns park blackheath by way of fixed charge all plant machinery implements utensils furniture and equipment and the goodwill of any business carried on by the company at the property.
    Personas con derecho
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transacciones
    • 06 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 29 ene 2008
    Entregado el 06 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transacciones
    • 06 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 27 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 19 ene 2006
    Entregado el 26 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 178-180 overhill road dulwich london t/no SGL301518 and SGL30926 by way of fixed charge the goodwill all plant machinery equipment furniture.
    Personas con derecho
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transacciones
    • 26 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 14 jun 2002
    Entregado el 03 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The freehold property known as 256 andover road newbury berkshire t/no: BK165578 by way of fixed charge the goodwill.by way of floating charge all plant machinery equipment furniture and other chattel assets.
    Personas con derecho
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transacciones
    • 03 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 01 oct 2001
    Entregado el 03 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a land at the rear of 36 high street thatcham berkshire t/no: BK364509.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of substituted security
    Creado el 15 nov 1999
    Entregado el 30 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a 17D st johns park london SE3 t/n TGL103858 with all buildings fixtures fixed plant and machinery goodwill and benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 30 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 15 nov 1999
    Entregado el 17 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a 4 st johns park blackheath l/b of greenwich.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1999
    Entregado el 25 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    17D st johns park,blackheath,london borough of greenwich; TGL103858.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 15 may 1998
    Entregado el 29 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    149 woodwarde road london borough of southwark.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 06 may 1998
    Entregado el 19 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 28 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 19 dic 1996
    Entregado el 31 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 55 overhill road dulwich l/b of southwark t/no. LN15131 and the proceeds opf sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 31 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 19 dic 1996
    Entregado el 31 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 59 overhill road dulwich l/b of southwark t/no.LN17570 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 31 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 17 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0