TADPOLES NURSERIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TADPOLES NURSERIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02794867 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TADPOLES NURSERIES LIMITED?
- Educación preescolar (85100) / Educación
- Actividades de cuidado diurno de niños (88910) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra TADPOLES NURSERIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2 Crown Way NN10 6BS Rushden Northamptonshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TADPOLES NURSERIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TADPOLES NURSERIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Walter Tugendhat como director el 10 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Mary Ann Tocio como director el 01 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 10 abr 2014 au 31 dic 2013 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 10 abr 2013 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Dreier como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Elizabeth Boland como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rosamund Marshall como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mary Ann Tocio como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Lissy como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Kramer como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Catherine Houghton como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Darren Powell como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TADPOLES NURSERIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER, Stephen | Secretario | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | 177501480001 | |||||||
| BOLAND, Elizabeth | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | United States | American | 70853820001 | |||||
| DREIER, Stephen | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | United States | American | 170443250001 | |||||
| LISSY, Dave | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | United States | American | 218331690001 | |||||
| TUGENDHAT, James Walter | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United Kingdom | British | 218306870001 | |||||
| ARNOLD, Shane | Secretario | 34 Highclove Lane M28 1GZ Worsley Lancashire | British | 106525210001 | ||||||
| CHADWICK, Claire Marie | Secretario | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | 168034480001 | |||||||
| LANG, Jacqueline Mary | Secretario | Wigton House Wigton Lane Alwoodley LS17 8SJ Leeds West Yorkshire | British | 3648270001 | ||||||
| MARSHALL, Rosamund Margaret | Secretario | Kidsunlimited Summerfields Village Centre SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow Cheshire | British | 157022630001 | ||||||
| PEARSON, James Lee | Secretario | Rookery Cottages Chester Road Hartford CW8 1LL Northwich 4 Cheshire United Kingdom | British | 185162450001 | ||||||
| TARPLEE, Beverley Anne | Secretario | 14 Falcon Terrace NE41 8EE Wylam Northumberland | British | 46418770003 | ||||||
| THOMPSON, Paul Simon | Secretario | Kidsunlimited Summerfields Village Centre SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow Cheshire | British | 149568090001 | ||||||
| RWL REGISTRARS LIMITED | Secretario designado corporativo | Regis House 134 Percival Road EN1 1QU Enfield Middlesex | 900007870001 | |||||||
| BACH, Karen | Director | Kent Street RH13 8BE Cowfold Potts Cottage W Sussex Uk | United Kingdom | British | 160940730001 | |||||
| CLARK, Jeremy | Director | Willington Road Willington CW6 0ND Tarporley 3 Oak Bank Cheshire England | England | British | 153453360001 | |||||
| HOLLOWAY, Adam Stuart | Director | Flat 1 231-5 Liverpool Road Islington N1 1LX London | United Kingdom | British | 80088960001 | |||||
| HOUGHTON, Catherine Laura Jane | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | England | British | 140056480001 | |||||
| LANG, Martin Allen | Director | Wigton House Wigton Lane Alwoodley LS17 8SJ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British, | 4153450001 | |||||
| MARSHALL, Rosamund Margaret | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | United Kingdom | British | 149527430001 | |||||
| PEARSON, James Lee | Director | Rookery Cottages Chester Road Hartford CW8 1LL Northwich 4 Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 185162450001 | |||||
| POWELL, Darren Roy | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | England | British | 169093510001 | |||||
| SMITH, Graham | Director | Kidsunlimited Summerfields Village Centre SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow Cheshire | United Kingdom | British | 142125320001 | |||||
| TOCIO, Mary Ann | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | Usa | Usa | 177507090001 | |||||
| WINSTANLEY, Christopher Robert | Director | Clayton Greaves House Hope Lane Adlington SK10 4NX Stockport Cheshire | British | 82735530001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TADPOLES NURSERIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Horizons Family Solutions Limited | 26 ene 2017 | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene TADPOLES NURSERIES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Creado el 04 abr 2008 Entregado el 12 abr 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 nov 2007 Entregado el 21 nov 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 ene 1997 Entregado el 09 ene 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 338/340 kirkstall road leeds west yorkshire t/nos.WYK533038 and WYK490591. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 14 jun 1993 Entregado el 26 jun 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0