SINGLEPOINT (4U) LIMITED

SINGLEPOINT (4U) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSINGLEPOINT (4U) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02795597
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    4U LIMITED03 oct 199403 oct 1994
    CAUDWELL AIRTIME SERVICES LIMITED28 may 199328 may 1993
    HAJCO 117 LIMITED03 mar 199303 mar 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 15 mar 2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Nombramiento de Mrs Janine Butler como director el 23 feb 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Nigel Evans como director el 23 feb 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 6

    2 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2019

    10 páginasAA

    legacy

    256 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Nombramiento de Mr Andrew Michael Yorston como director el 02 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Diane Josephine Mcintyre como director el 16 mar 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    5 páginasAA

    Cancelación total de la carga 5

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    2 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario corporativo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    75473330004
    BUTLER, Janine
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector277534960001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector257275320001
    BENNETT, Craig
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishDirector34704080001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    HAJCO SECRETARIES LIMITED
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Secretario designado corporativo
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    900006890001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector123612980001
    BARTON, John Michael
    30 Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    Middlesex
    Director
    30 Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    Middlesex
    BritishManaging Director34831450001
    BENNETT, Craig
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishFinance Director34704080001
    BIRNEY, James Gary
    Three Acre Wood
    Bridgemere Lane
    CW5 7PL Nantwich
    Cheshire
    Director
    Three Acre Wood
    Bridgemere Lane
    CW5 7PL Nantwich
    Cheshire
    BritishDirector86869670001
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Director
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    BritishDirector83126790001
    BROWN, Peter
    Hawthorne Cottage
    19 Station Road Barlaston
    ST12 9DH Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Director
    Hawthorne Cottage
    19 Station Road Barlaston
    ST12 9DH Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    BritishSales Director58317370001
    CAUDWELL, Brian
    Fradswell Hall Fradswell
    ST18 0EX Stafford
    Staffordshire
    England
    Director
    Fradswell Hall Fradswell
    ST18 0EX Stafford
    Staffordshire
    England
    BritishCompany Director15920410002
    CAUDWELL, John David
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    Director
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    EnglandBritishManaging Director21185880002
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector99525280001
    DARBY, Gavin John
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    Director
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishDirector99277850001
    DAVIES, Andrew Mark
    19 Burnside
    WA15 0SG Halebarns
    Cheshire
    Director
    19 Burnside
    WA15 0SG Halebarns
    Cheshire
    BritishDirector86869710001
    DOBSON, Philip
    The Holtridge
    Norbury Nr Cholmondeley
    SY13 4JA Whitchurch
    Shropshire
    Director
    The Holtridge
    Norbury Nr Cholmondeley
    SY13 4JA Whitchurch
    Shropshire
    BritishDirector95437530001
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    HUMPHREYS, Christopher Andrew
    Bowden House
    Bowden Lane, Marple
    SK6 6ND Stockport
    Cheshire
    Director
    Bowden House
    Bowden Lane, Marple
    SK6 6ND Stockport
    Cheshire
    BritishDirector77737010001
    JACKSON, Stephen Paul
    11 Pollard Drive
    Stapeley
    CW5 7EQ Nantwich
    Cheshire
    Director
    11 Pollard Drive
    Stapeley
    CW5 7EQ Nantwich
    Cheshire
    BritishFinancial Director74412960001
    KEAYS, Helen Margaret
    The Old Vicarage
    Temple Grafton
    B49 6NX Alcester
    Warwickshire
    Director
    The Old Vicarage
    Temple Grafton
    B49 6NX Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector81221470001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Director
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritishDirector24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    MORROW, William Thomas
    5415 Blackhawk Drive
    Danville
    California 94506
    Usa
    Director
    5415 Blackhawk Drive
    Danville
    California 94506
    Usa
    AmericanDirector95677940001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGermanDirector174443800001
    PHILLIPS, Thomas Adam
    The Old Stable House Sun Farm
    Fradswell
    ST18 0EY Stafford
    Director
    The Old Stable House Sun Farm
    Fradswell
    ST18 0EY Stafford
    United KingdomBritishDirector55928770001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director87149560001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance Technology & Support158146600001
    STEWART, Gregory Kenneth
    1 The Grove
    CW6 0GB Tarporley
    Cheshire
    Director
    1 The Grove
    CW6 0GB Tarporley
    Cheshire
    BritishIt Director80561450001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalianDirector103542080002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2227940
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene SINGLEPOINT (4U) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 03 feb 2003
    Entregado el 14 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 26 mar 2002
    Entregado el 03 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All claims choses in action intellectual property and goodwill of the company present and future in so far as the same are comprised in the subscriber base arising under the service provider agreement and any other rights benefits or interests now and in the future comprised in the subscriber base. All book debts now and in the future owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bt Cellnet
    Transacciones
    • 03 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge
    Creado el 03 ene 2002
    Entregado el 16 ene 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first floating charge its undertaking and assets both present and future.
    Personas con derecho
    • Vodafone Limited
    Transacciones
    • 16 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 06 dic 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 22 dic 1997
    Entregado el 29 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 22 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 dic 1994
    Entregado el 15 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 22 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 sept 1994
    Entregado el 23 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 23 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 22 jul 1993
    Entregado el 24 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreements or either of them or any subsequent agreement (as defined)
    Breve descripción
    The interest of the company in its customers from time to time concerning or inrelation to telecommunications services provided in whole or part on the vodafone network and all goodwill associated therewith (the subscriber base), first fixed charge all goodwill and uncalled capital intellectual property rights all book debts and other debts and first floating charge charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Vodafone Limited
    Transacciones
    • 24 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 06 dic 2018Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0