FIRST RADIO SALES LIMITED

FIRST RADIO SALES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFIRST RADIO SALES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02795622
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FIRST RADIO SALES LIMITED?

    • Agencias de publicidad (73110) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra FIRST RADIO SALES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FIRST RADIO SALES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RADIO SALES LIMITED12 nov 200212 nov 2002
    CLEAR CHANNEL RADIO SALES LIMITED13 jun 200013 jun 2000
    KATZ INTERNATIONAL LIMITED06 may 199306 may 1993
    SABREMOUNT SERVICES LIMITED03 mar 199303 mar 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FIRST RADIO SALES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FIRST RADIO SALES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 08 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2020

    7 páginasAA

    legacy

    46 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 sept 2020 au 31 dic 2020

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 08 ene 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2019

    7 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 29 jul 2020

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Scott William Taunton como director el 30 abr 2020

    1 páginasTM01

    Modification des détails de Ukrd Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 abr 2020

    2 páginasPSC05

    Cessation de Wireless Group Media (Gb) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 abr 2020

    1 páginasPSC07

    Cese del nombramiento de Andrew Preece como director el 30 abr 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Michael Buckland como director el 30 abr 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Preece como secretario el 30 abr 2020

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Bauer Group Secretariat Ltd como secretario el 30 abr 2020

    2 páginasAP04

    Nombramiento de Mrs Deidre Ann Ford como director el 30 abr 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Sarah Jane Vickery como director el 30 abr 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Anthony Keenan como director el 30 abr 2020

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de FIRST RADIO SALES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LTD
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Secretario corporativo
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro944753
    270106790001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    EnglandBritish119137220004
    EMENY, Selina Holliday
    32 Defoe Avenue
    Kew
    TW9 4DT Richmond
    Secretario
    32 Defoe Avenue
    Kew
    TW9 4DT Richmond
    British76404320001
    FENNELL, Andrew Phillip
    Stanley Hill Avenue
    HP7 9BD Amersham
    6
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Stanley Hill Avenue
    HP7 9BD Amersham
    6
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    English135981330001
    FENNELL, Andrew Phillip
    Stanley Hill Avenue
    HP7 9BD Amersham
    6
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Stanley Hill Avenue
    HP7 9BD Amersham
    6
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    English135981330001
    KILBY, Stuart Peter
    41 Bilberry Close
    Whitefield
    M45 8BL Manchester
    Secretario
    41 Bilberry Close
    Whitefield
    M45 8BL Manchester
    British85175910001
    LAWLEY, Garth Anthony
    Hurst Cottage Bradcutts Lane
    Cookham Dean
    SL6 9AB Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Hurst Cottage Bradcutts Lane
    Cookham Dean
    SL6 9AB Maidenhead
    Berkshire
    British52158790001
    MAUNDER, Timothy John
    Dragons City
    Bledlow Ridge
    HP14 4AB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secretario
    Dragons City
    Bledlow Ridge
    HP14 4AB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British62543060001
    MCARTHUR, Ronald James
    71 Ripplevale Grove
    Islington
    N1 1HS London
    Secretario
    71 Ripplevale Grove
    Islington
    N1 1HS London
    British32058430001
    MOORE, Debbie
    71 Pitcairn House
    St Thomas's Square
    E9 6PU Hackney
    London
    Secretario designado
    71 Pitcairn House
    St Thomas's Square
    E9 6PU Hackney
    London
    British900007470001
    PREECE, Andrew
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    Secretario
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    186953630001
    SCHLAGMAN, Michael Edward
    56 Fitzalan Road
    Finchley
    N3 3PE London
    Secretario
    56 Fitzalan Road
    Finchley
    N3 3PE London
    British32752590002
    WELLS, Lynette Ann
    Little Croft
    Maple Walk
    TN39 4SN Bexhill On Sea
    East Sussex
    Secretario
    Little Croft
    Maple Walk
    TN39 4SN Bexhill On Sea
    East Sussex
    British98242040001
    WOODS, Sian
    Studios
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea
    Cornwall
    United Kingdom
    Secretario
    Studios
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea
    Cornwall
    United Kingdom
    British138145820001
    BELOYIANIS, James E
    125 W55th Street
    New York
    10019
    Usa
    Director
    125 W55th Street
    New York
    10019
    Usa
    American62884380001
    BOWLES, Howard
    Cleeve House
    Main Road
    HP27 0QN Lacey Green
    Buckinghamshire
    Director
    Cleeve House
    Main Road
    HP27 0QN Lacey Green
    Buckinghamshire
    Australian124988670001
    BROWN, Kevin Thomas
    30 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Director designado
    30 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish900008020001
    BUCKLAND, James Michael
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    Director
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish180975020001
    CASTRO, Nicholas
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    Director
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    EnglandBritish39006500001
    CONROY III, John Francis
    2 Kings Yard
    Stanbridge Road
    SW15 1DE London
    Director
    2 Kings Yard
    Stanbridge Road
    SW15 1DE London
    American73948560001
    DAMON, Robert
    54 Quebec Drive
    Huntington Station
    New York
    11746
    Usa
    Director
    54 Quebec Drive
    Huntington Station
    New York
    11746
    Usa
    American62884460001
    FENNELL, Andrew Phillip
    Stanley Hill Avenue
    HP7 9BD Amersham
    6
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Stanley Hill Avenue
    HP7 9BD Amersham
    6
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomEnglish135981330001
    GOULAZIAN, Peter
    Katz Corporation
    125 West 55th Street New York 10019
    FOREIGN Usa
    Director
    Katz Corporation
    125 West 55th Street New York 10019
    FOREIGN Usa
    American35209690001
    GREENWALD, James
    125 West 55th Treet
    New York New York State 10019
    FOREIGN Usa
    Director
    125 West 55th Treet
    New York New York State 10019
    FOREIGN Usa
    American35209700001
    LAWLEY, Garth Anthony
    Hurst Cottage Bradcutts Lane
    Cookham Dean
    SL6 9AB Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Hurst Cottage Bradcutts Lane
    Cookham Dean
    SL6 9AB Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish52158790001
    LLOYD, Humphrey Alexander
    The Old Coach House
    Wycombe Road Studley Green
    HP14 3XB High Wycombe
    Director
    The Old Coach House
    Wycombe Road Studley Green
    HP14 3XB High Wycombe
    British22345580004
    LYNDS, Simon Walter
    Block 4 Flat 4r Portman Mansions
    Chiltern Street
    W1M 1LF London
    Director
    Block 4 Flat 4r Portman Mansions
    Chiltern Street
    W1M 1LF London
    British60221850002
    MACAULAY, Callum Roderick
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    Director
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish182163470001
    MACKENZIE, Alistair William
    142 Widmore Road
    BR1 3BP Bromley
    Director
    142 Widmore Road
    BR1 3BP Bromley
    British38279630005
    MAROCCO, Michael J
    Sandler Media Group 767 5th Avenue
    45th Floor New York 10153
    FOREIGN Usa
    Director
    Sandler Media Group 767 5th Avenue
    45th Floor New York 10153
    FOREIGN Usa
    American35209680001
    MCANN, John
    175 Malone Road
    BT9 6TB Belfast
    County Antrim
    Director
    175 Malone Road
    BT9 6TB Belfast
    County Antrim
    British108977390001
    MCARTHUR, Ronald James
    71 Ripplevale Grove
    Islington
    N1 1HS London
    Director
    71 Ripplevale Grove
    Islington
    N1 1HS London
    EnglandBritish32058430001
    MYERS, John Frederick
    21 Middle Drive
    Darras Hal
    NE20 9DH Ponteland
    Northumberland
    Director
    21 Middle Drive
    Darras Hal
    NE20 9DH Ponteland
    Northumberland
    British70386430001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de FIRST RADIO SALES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    401 Faraday Street
    Birchwood Park
    WA3 6GA Warrington
    Ground Floor
    United Kingdom
    07 jul 2016
    401 Faraday Street
    Birchwood Park
    WA3 6GA Warrington
    Ground Floor
    United Kingdom
    Forma jurídicaCorporate
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03949697
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06 abr 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02725453
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene FIRST RADIO SALES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 19 ene 2004
    Entregado el 20 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £22,783.25, an interest bearing account in the name of the tenant, the amount from time to time standing to the credit of the deposit account, all interest credited to the deposit account.
    Personas con derecho
    • Derwent Valley Central Limited
    Transacciones
    • 20 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 19 oct 1999
    Entregado el 20 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from chancellor media corporation of los angeles (formerly known as evergreen media corp.of los angeles) and its subsidiaries to the chargee,the lenders and the issuing bank (each as defined in a second amended and restated loan agreement dated 25 april 1997)
    Breve descripción
    All right,title and interest in and to 65% of all capital stock in katz television sales LTD and all stocks,shares,warrants,dividends,income,property,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Toronto Dominion (Texas),Inc.as Collateral and Administrative Agent
    Transacciones
    • 20 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 19 oct 1999
    Entregado el 20 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from chancellor media corporation of los angeles (formerly known as evergreen media corp.of los angeles) and its subsidiaries to the chargee,the lenders and the issuing bank (each as defined in a second amended and restated loan agreement dated 25 april 1997)
    Breve descripción
    All right,title and interest in and to 65% of all capital stock in katz radio sales LTD and all stocks,shares,dividends,income,property,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Toronto Dominion (Texas),Inc.as Collateral and Administrative Agent
    Transacciones
    • 20 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 19 oct 1999
    Entregado el 20 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from chancellor media corporation of los angeles (formerly known as evergreen media corp.of los angeles) and its subsidiaries to the chargee,the lenders and the issuing bank (each as defined in a second amended and restated loan agreement dated 25 april 1997)
    Breve descripción
    All right title and interest in and to 65% of all capital stock in katz U.K.LTD and all stocks,shares,warrants,dividends,income,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Toronto Dominion (Texas),Inc.,as Collateral and Administrative Agent
    Transacciones
    • 20 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 19 oct 1999
    Entregado el 20 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from chancellor media corporation of los angeles (formerly known as evergreen media corp. Of los angeles) and its subsidiaries to the chargee,the lenders and the issuing bank (each as defined in a second amended and restated loan agreement dated 25 april 1997)
    Breve descripción
    All right,title and interest in and to (I) 65% of the capital stock in independent radio sales LTD,(ii) all stocks,shares,warrants,options,dividends,interest,income and other benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Toronto Dominion (Texas),Inc. as Collateral Agent and Administrative Agent
    Transacciones
    • 20 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 24 sept 1993
    Entregado el 07 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date and the sum of £32,205 plus V.A.T. which may become due under clause 6.2.2. of the said lease
    Breve descripción
    The sum of £71,190 together with any other sum paid into a specifically designated solicitors deposit account to be held by manches & co and interest credited to the said account.
    Personas con derecho
    • Lynton Investments Limited
    Transacciones
    • 07 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 17 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0