SIGNATURE INDUSTRIES LIMITED

SIGNATURE INDUSTRIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSIGNATURE INDUSTRIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02800561
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SIGNATURE INDUSTRIES LIMITED?

    • Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra SIGNATURE INDUSTRIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIGNATURE INDUSTRIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GREATNOTCH LIMITED17 mar 199317 mar 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SIGNATURE INDUSTRIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIGNATURE INDUSTRIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    14 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 mar 2016

    13 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order INSOLVENCY:o/c replacement liquidator
    11 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 mar 2015

    16 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq
    17 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Rsm Tenon Restructuring 34 Clarendon Road Watford Hertfordshire WD11 1JJ a The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1BP el 17 mar 2015

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:court order - replacement of liquidator
    13 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 mar 2014

    14 páginas4.68

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    3 páginasF10.2

    Domicilio social registrado cambiado de * Units 29-31 the Base Dartford Business Park Victoria Road Dartford Kent DA1 5FS United Kingdom* el 08 abr 2013

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    5 páginas4.20

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación

    LRESEX

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Cese del nombramiento de Michael Cook como secretario

    2 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 12 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 mar 2013

    Estado de capital el 27 mar 2013

    • Capital: GBP 370,000.1
    SH01

    legacy

    3 páginasMG02

    Cese del nombramiento de Michael Cook como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Grant como director

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SIGNATURE INDUSTRIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GRILLO, Joseph James
    670 Pequot Ave
    New London
    Connecticut 06320
    Usa
    Director
    670 Pequot Ave
    New London
    Connecticut 06320
    Usa
    United StatesAmericanC E O221453840001
    COOK, Michael Roy, Dr
    17 Northbourne Road
    ME8 6QN Gillingham
    Kent
    Secretario
    17 Northbourne Road
    ME8 6QN Gillingham
    Kent
    BritishHead Of Finance101831460001
    TYLER, Robin Montague
    15 Fairhurst Drive
    East Farleigh
    ME15 0DF Maidstone
    Kent
    Secretario
    15 Fairhurst Drive
    East Farleigh
    ME15 0DF Maidstone
    Kent
    British34197190004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TKB REGISTRARS LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Secretario designado corporativo
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900002650001
    ARCHER, Brent Chandler
    Gilbert Stuart Drive
    East Greenwich
    Rhode Island
    10
    02818
    Usa
    Director
    Gilbert Stuart Drive
    East Greenwich
    Rhode Island
    10
    02818
    Usa
    UsaAmericanDirector135255960001
    BASSETT, Frederick Walter
    141 Main Road
    DA4 9HW Sutton At Hone
    Kent
    Director
    141 Main Road
    DA4 9HW Sutton At Hone
    Kent
    United KingdomBritishOperations Director88132570001
    BOOKER, John Albert
    Ivy House 43 Church Street
    Buckden
    PE18 9TP Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Ivy House 43 Church Street
    Buckden
    PE18 9TP Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director5944410001
    BREECE, Lorraine Morris
    West Palm Beach
    Florida
    3007 Washington Road
    33405
    Usa
    Director
    West Palm Beach
    Florida
    3007 Washington Road
    33405
    Usa
    UsaAmericanDirector135255750001
    CAIRNIE, David Mellon
    24 Brook Lane
    CM21 0EL Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Director
    24 Brook Lane
    CM21 0EL Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishManaging Director34178920001
    CLAYTON, Robert Brian
    10 Pishiobury Drive
    CM21 0AE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Director
    10 Pishiobury Drive
    CM21 0AE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishGeneral Manager140321060001
    COOK, Alan Ernest
    Dalton House
    Lindsell
    CM6 3QL Dunmow
    Essex
    Director
    Dalton House
    Lindsell
    CM6 3QL Dunmow
    Essex
    BritishGeneral Manager59931160001
    COOK, Michael Roy, Dr
    17 Northbourne Road
    ME8 6QN Gillingham
    Kent
    Director
    17 Northbourne Road
    ME8 6QN Gillingham
    Kent
    United KingdomBritishCommercial Director101831460001
    EDELSTEIN, Barry
    1100 Green Valley Road,
    Bryn Mawr
    Pa19010
    Usa
    Director
    1100 Green Valley Road,
    Bryn Mawr
    Pa19010
    Usa
    AmericanDirector125107520001
    GAGE, Trevor Gerald
    2 Quilberry Drive Queensborough Lane
    Great Notley Garden Village
    CM77 7QD Braintree
    Essex
    Director
    2 Quilberry Drive Queensborough Lane
    Great Notley Garden Village
    CM77 7QD Braintree
    Essex
    EnglandBritishGeneral Manager82996740002
    GORDON, Peter
    8 Chestnut Walk
    SG1 4DD Old Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    8 Chestnut Walk
    SG1 4DD Old Stevenage
    Hertfordshire
    BritishAccountant41529970001
    GRANT, John Joseph
    11 Monikie Gardens
    Bishopbriggs
    G64 1XY Glasgow
    Director
    11 Monikie Gardens
    Bishopbriggs
    G64 1XY Glasgow
    ScotlandBritishGeneral Manager85351150001
    HAY, Roger Owen
    27 Boscastle Road
    NW5 1EE London
    Director
    27 Boscastle Road
    NW5 1EE London
    BritishVenture Capitilist2568980001
    HESS JR, Parke Hoffman
    Clearview Overlook
    Crestone
    Colorado
    2300
    81131
    Usa
    Director
    Clearview Overlook
    Crestone
    Colorado
    2300
    81131
    Usa
    UsaAmericanDirector135255810001
    MARTIN, Peter William, Mr.
    26 Grove Road
    W5 5DS Ealing
    London
    England
    Director
    26 Grove Road
    W5 5DS Ealing
    London
    England
    BritishSolicitor63564140001
    MCGRATH, Kevin
    3778 Coventry Lane
    Boca Raton
    Palm Beach County 33496
    Usa
    Director
    3778 Coventry Lane
    Boca Raton
    Palm Beach County 33496
    Usa
    UsaPresident Digitalangel96629940001
    O'KEEFFE, Richard Kevin
    56 Flask Walk
    Hampstead
    NW3 1HE London
    Director
    56 Flask Walk
    Hampstead
    NW3 1HE London
    BritishEconomist14239310001
    PETERSEN, Patricia Marie
    Montclaire Court
    Weston
    Florida
    2534
    33327
    Usa
    Director
    Montclaire Court
    Weston
    Florida
    2534
    33327
    Usa
    UsaAmericanDirector135255880001
    SALKELD, Ian
    30 Felstead Road
    Wanstead
    E11 2QJ London
    Director
    30 Felstead Road
    Wanstead
    E11 2QJ London
    BritishInvestment Manager52338990001
    SANTELLI, James
    496 Villaume Ave
    South St Paul
    55075
    Usa
    Director
    496 Villaume Ave
    South St Paul
    55075
    Usa
    UsaDirector86552570001
    SAYLES, Peter David
    85 Redhill Wood
    New Ash Green
    DA3 8QP Longfield
    Kent
    Director
    85 Redhill Wood
    New Ash Green
    DA3 8QP Longfield
    Kent
    BritishCompany Director11975510001
    SULLIVAN, David Melton
    Forest Road
    Saint Louis Park
    4000
    Mn 55416
    Usa
    Director
    Forest Road
    Saint Louis Park
    4000
    Mn 55416
    Usa
    UsaAmericanDirector135256010001
    TYLER, Robin Montague
    15 Fairhurst Drive
    East Farleigh
    ME15 0DF Maidstone
    Kent
    Director
    15 Fairhurst Drive
    East Farleigh
    ME15 0DF Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishFinance Director34197190004
    TYLER, Robin Montague
    15 Fairhurst Drive
    East Farleigh
    ME15 0DF Maidstone
    Kent
    Director
    15 Fairhurst Drive
    East Farleigh
    ME15 0DF Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishFinance Director34197190004
    WANSBROUGH, David George Rawdon
    Salterns End
    Kings Saltern Road
    SO41 3QH Lymington
    Hampshire
    Director
    Salterns End
    Kings Saltern Road
    SO41 3QH Lymington
    Hampshire
    EnglandBritishInvestment Manager47849990002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene SIGNATURE INDUSTRIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 08 jul 2009
    Entregado el 09 jul 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bibby Financial Services Limited
    Transacciones
    • 09 jul 2009Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    • 16 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    • 05 may 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    • 19 may 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    • 23 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    • 06 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creado el 05 feb 2008
    Entregado el 14 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account designation 73600342 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 25 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creado el 10 sept 2007
    Entregado el 15 sept 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account designation 73600342 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 sept 2007Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 feb 2007
    Entregado el 22 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and all of the company subsidiaries to the chargee or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Imperium Advisers, Llc (The Security Agent)
    Transacciones
    • 22 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 29 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 12 may 2003
    Entregado el 14 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 14 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creado el 13 mar 2003
    Entregado el 20 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account designation 73508152 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of deposit
    Creado el 13 mar 2003
    Entregado el 20 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account designation 73508160 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 abr 1993
    Entregado el 19 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene SIGNATURE INDUSTRIES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    25 mar 2013Inicio de la liquidación
    10 ago 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Peter James Hughes-Holland
    34 Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    Hertfordshire
    Profesional
    34 Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    Hertfordshire
    Nicholas Simmonds
    34 Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    Profesional
    34 Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    Richard Patrick Brewer
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Profesional
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Graham Paul Bushby
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Profesional
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Christopher Cooke
    The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Profesional
    The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0