MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED

MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02801072
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    • Otras ediciones de software (58290) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE FRUSTUM GROUP (EUROPE) LIMITED18 mar 199318 mar 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 may 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 01 abr 2015

    • Capital: USD 3,890,770
    4 páginasSH01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Déclaration annuelle établie au 18 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 mar 2015

    Estado de capital el 27 mar 2015

    • Capital: USD 6,900
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2014

    11 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Paul Woodward como director el 05 sept 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sanjay Patel como director el 28 ago 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr John Van Harken como director el 31 jul 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Mary Collins como director el 31 jul 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 18 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 mar 2014

    Estado de capital el 24 mar 2014

    • Capital: USD 6,900
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2013

    11 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Elizabeth Mary Collins como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Misys Corporate Director Limited como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Joanna Hawkes como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Misys Corporate Secretary Limited como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Sanjay Patel como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Joanna Marageret Hawkes como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Bijal Patel como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Thomas Edward Timothy Homer el 20 may 2013

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 18 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2012

    12 páginasAA

    Cese del nombramiento de Nicholas Farrimond como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Bijal Mahendra Patel como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    BAINS, Gurbinder
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Other138753780001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    STOKOE, Anthony
    4 Clifton Road
    KT2 6PW Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    4 Clifton Road
    KT2 6PW Kingston Upon Thames
    Surrey
    British29734520002
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro07036299
    149996410001
    SECORP LIMITED
    PO BOX 556, Hunkins Waterfront
    Plaza, Main Street
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    Secretario corporativo
    PO BOX 556, Hunkins Waterfront
    Plaza, Main Street
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    93219460001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    DARBY, Andrew Hamish
    9a Oatlands Chase
    KT13 9RF Weybridge
    Surrey
    Director
    9a Oatlands Chase
    KT13 9RF Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish114800800001
    DAVIS, Steven Rogers
    71 Gerrish Lane
    New Canaan
    Connecticut
    06840
    Usa
    Director
    71 Gerrish Lane
    New Canaan
    Connecticut
    06840
    Usa
    United StatesAmerican42813140002
    DEMETRIOS, Helen
    316 Stonehill Road
    10576 Pound Ridge
    New York
    United States
    Director
    316 Stonehill Road
    10576 Pound Ridge
    New York
    United States
    American34271630002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    Director
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    EnglandBritish75357260001
    FLOCK, Charles
    42 West Clinton Avenue
    10533 Irvington
    New Yok
    United States Of America
    Director
    42 West Clinton Avenue
    10533 Irvington
    New Yok
    United States Of America
    American34271860002
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Director
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HELSBY, Frank Peter
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    Director
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish34237710003
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    Director
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    JAUFERING, Robert Russell
    5 Monck Street
    SW1P 2BW London
    Director
    5 Monck Street
    SW1P 2BW London
    American37636270001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Director
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    PEDDAR, Richard Granville
    14 Lower Common South
    Putney
    SW15 1BP London
    Director
    14 Lower Common South
    Putney
    SW15 1BP London
    British57803270001
    SOMMERS, Gary
    10 Shoshone Drive
    10526 Golders Bridge
    New York
    United States
    Director
    10 Shoshone Drive
    10526 Golders Bridge
    New York
    United States
    American34272070002
    SPADAFORA, Fred Jphn
    3 Heathview Court
    Corringway
    NW11 7EF London
    Director
    3 Heathview Court
    Corringway
    NW11 7EF London
    American52601930001
    STADTHER, Michael
    316 Stonehill Road
    10576 Pound Ridge
    New York
    United States
    Director
    316 Stonehill Road
    10576 Pound Ridge
    New York
    United States
    American34271760002
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Director
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    WHITE, Andrew Ian
    Hillcott
    Perrotts Brook
    GL7 7BN Cirencester
    Glos
    Director
    Hillcott
    Perrotts Brook
    GL7 7BN Cirencester
    Glos
    United KingdomBritish93602410001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    Director corporativo
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    82836510002

    ¿Tiene MISYS OPEN SOURCE SOLUTIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creado el 17 sept 2003
    Entregado el 01 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creado el 11 sept 2003
    Entregado el 24 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creado el 29 jul 2003
    Entregado el 12 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creado el 23 oct 2002
    Entregado el 13 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Creado el 09 may 2002
    Entregado el 25 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 25 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0