DMX MUSIC UK LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDMX MUSIC UK LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02802596
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DMX MUSIC UK LTD?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DMX MUSIC UK LTD?

    Dirección de la sede social
    3 New Street
    YO1 8RA York
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DMX MUSIC UK LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AEI MUSIC NETWORK LIMITED17 ago 199817 ago 1998
    AEI MUSIC LIMITED15 jun 199315 jun 1993
    FC1038 LIMITED23 mar 199323 mar 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DMX MUSIC UK LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DMX MUSIC UK LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    16 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de West House 46 High Street Orpington Kent BR6 0JQ England a 3 New Street York YO1 8RA el 08 ene 2018

    1 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    9 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 nov 2017

    LRESSP

    Estado de capital el 01 dic 2017

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 mar 2016

    Estado de capital el 24 mar 2016

    • Capital: GBP 3,238,290
    SH01

    Nombramiento de Mr Kenneth Eissing como director el 25 feb 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Claude Nahon como director el 25 feb 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Caroline Sarah Trenter como director el 25 feb 2016

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de Forest Lodge Westerham Road Keston Kent BR2 6HE a West House 46 High Street Orpington Kent BR6 0JQ el 11 sept 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    13 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Déclaration annuelle établie au 23 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 mar 2015

    Estado de capital el 23 mar 2015

    • Capital: GBP 3,238,290
    SH01

    Cese del nombramiento de Randal Joseph Rudniski como director el 16 jun 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    14 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Caroline Sarah Trenter como secretario el 12 sept 2014

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Richard Anthony D'cruz como secretario el 12 sept 2014

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de DMX MUSIC UK LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TRENTER, Caroline Sarah
    New Street
    YO1 8RA York
    3
    Secretario
    New Street
    YO1 8RA York
    3
    190910400001
    EISSING, Kenneth H.
    New Street
    YO1 8RA York
    3
    Director
    New Street
    YO1 8RA York
    3
    United StatesAmerican205614280001
    TRENTER, Caroline Sarah
    New Street
    YO1 8RA York
    3
    Director
    New Street
    YO1 8RA York
    3
    EnglandBritish205489350001
    D'CRUZ, Richard Anthony
    Forest Lodge
    Westerham Road
    BR2 6HE Keston
    Kent
    Secretario
    Forest Lodge
    Westerham Road
    BR2 6HE Keston
    Kent
    149609350001
    HAZELWOOD, Sarah Jane
    20 Goldsmid Road
    TN9 2BX Tonbridge
    Kent
    Secretario
    20 Goldsmid Road
    TN9 2BX Tonbridge
    Kent
    British55607950002
    MILES, Sallie Ann
    2632 North West 87th Street
    Seattle Washington 98117
    FOREIGN Usa
    Secretario
    2632 North West 87th Street
    Seattle Washington 98117
    FOREIGN Usa
    American36134210001
    SAUNDERS, David
    30 Swain Road
    ME8 0SN Gillingham
    Kent
    Secretario
    30 Swain Road
    ME8 0SN Gillingham
    Kent
    British76995460001
    TRENTER, Caroline Sarah Louise
    Serpentine Road
    TN13 3XP Sevenoaks
    4
    Kent
    Secretario
    Serpentine Road
    TN13 3XP Sevenoaks
    4
    Kent
    British118124720002
    YOUNGMAN, Kenneth John
    40 The Green
    Southgate
    N14 6EN London
    Secretario
    40 The Green
    Southgate
    N14 6EN London
    British76405430001
    LEGIST SECRETARIES LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Secretario designado corporativo
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    900006080001
    AYRAULT, Arthur Delancey
    1730 Evergreen Place
    FOREIGN Seattle
    Wa 98122
    Usa
    Director
    1730 Evergreen Place
    FOREIGN Seattle
    Wa 98122
    Usa
    American81221650001
    BAILEY, Mark Alexander Marshall
    17 Austenway
    Chalfont St Peter
    SL9 8NN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    17 Austenway
    Chalfont St Peter
    SL9 8NN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish108294640001
    BAXTER, Robert David
    13254 La Quinta St
    La Mirada
    California
    Ca90638
    Usa
    Director
    13254 La Quinta St
    La Mirada
    California
    Ca90638
    Usa
    American80919590001
    BECKER, William Allen
    Treetops
    Shoppenhangers Road
    SL6 2PZ Maidenhead
    Berkshire
    Usa
    Director
    Treetops
    Shoppenhangers Road
    SL6 2PZ Maidenhead
    Berkshire
    Usa
    American49500030001
    BEESLEY, Adrian Francis Mark
    6 Woodview Close
    Kingston Vale
    SW15 3RL London
    Director
    6 Woodview Close
    Kingston Vale
    SW15 3RL London
    British54801580002
    CAREY, Mark Andrew
    Manor Cottage
    South Street
    OX11 9PX Blewbury
    Oxfordshire
    Director
    Manor Cottage
    South Street
    OX11 9PX Blewbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish118790790001
    CLARK, Michael
    40 Glen View Road
    Old Greenhill
    S8 7SF Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    40 Glen View Road
    Old Greenhill
    S8 7SF Sheffield
    South Yorkshire
    British57851340001
    DAHL, Daniel John
    21534 S E 37th Street
    WA98027 Issaquah
    Washington
    Usa
    Director
    21534 S E 37th Street
    WA98027 Issaquah
    Washington
    Usa
    American36714740001
    GRABER, Stuart
    15 Heathgate
    NW11 7AR London
    Director
    15 Heathgate
    NW11 7AR London
    United KingdomAmerican71042580001
    GUJRAL, Ben
    Forest Lodge
    Westerham Road
    BR2 6HE Keston
    Kent
    Director
    Forest Lodge
    Westerham Road
    BR2 6HE Keston
    Kent
    United KingdomBritish117933240001
    HOGAN, William Robert
    Flat 7
    Sandringham Court 37 The Avenue
    BR3 5EE Beckenham
    Kent
    Director
    Flat 7
    Sandringham Court 37 The Avenue
    BR3 5EE Beckenham
    Kent
    American50882900001
    MALONE, Michael James
    900 East Pine Street
    Seattle
    98122 Washington
    Usa
    Director
    900 East Pine Street
    Seattle
    98122 Washington
    Usa
    Usa36257490001
    MATYSIK, Michael Karl
    23627 74th Avenue West
    98026 Edmonds
    Wa
    Usa
    Director
    23627 74th Avenue West
    98026 Edmonds
    Wa
    Usa
    American51123840001
    MENSINK, Maurice William
    Zwaluwlaan 100
    1403 Bl Bussum
    FOREIGN Netherlands
    Director
    Zwaluwlaan 100
    1403 Bl Bussum
    FOREIGN Netherlands
    Dutch42722210001
    MOUNTBATTEN, Ivar Alexander Michael, Lord
    Bridwell Park
    Uffculme
    EX15 3BU Cullompton
    Devon
    Director
    Bridwell Park
    Uffculme
    EX15 3BU Cullompton
    Devon
    EnglandBritish46140520002
    NAHON, Claude
    46 High Street
    BR6 0JQ Orpington
    West House
    Kent
    England
    Director
    46 High Street
    BR6 0JQ Orpington
    West House
    Kent
    England
    FranceFrench188551320001
    PATRICK, Jonathan
    North End
    RG20 0BA Newbury
    Ansell House
    Berkshire
    Director
    North End
    RG20 0BA Newbury
    Ansell House
    Berkshire
    EnglandBritish133718670001
    PROBERT, Gregory Lee
    1440 St Albans Road
    San Marino, California
    Ca 91108
    United States
    Director
    1440 St Albans Road
    San Marino, California
    Ca 91108
    United States
    United StatesAmerican56332270001
    RING, Christopher David
    Crown Cottage
    Groombridge Hill Groombridge
    TN3 9QE Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Crown Cottage
    Groombridge Hill Groombridge
    TN3 9QE Tunbridge Wells
    Kent
    British45083070001
    ROBERTS, David Wynne
    Wayside House
    Shinfield Road Shinfield
    RG2 9BE Reading
    Berkshire
    Director
    Wayside House
    Shinfield Road Shinfield
    RG2 9BE Reading
    Berkshire
    British81016310001
    RUDNISKI, Randal Joseph
    Forest Lodge
    Westerham Road
    BR2 6HE Keston
    Kent
    Director
    Forest Lodge
    Westerham Road
    BR2 6HE Keston
    Kent
    United StatesCanadian182919080001
    SKINNER, Paul W
    3821 East Pine Street
    Seattle
    Washington 98112
    Usa
    Director
    3821 East Pine Street
    Seattle
    Washington 98112
    Usa
    American46468770001
    STEAD, Paul
    65 Slayley View Road
    Barlborough
    S43 4UQ Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    65 Slayley View Road
    Barlborough
    S43 4UQ Chesterfield
    Derbyshire
    United KingdomBritish67613040001
    VON STAUFFENBERG, Philippe Friedrich Maria De Spiritu Sanctu Schenk Graf
    120 Castelnau
    SW13 9EU London
    Director
    120 Castelnau
    SW13 9EU London
    EnglandBritish,German71123620001
    WHEELHOUSE, Kevin Paul
    25 Carisbrooke Drive
    NG3 5DS Nottingham
    Director
    25 Carisbrooke Drive
    NG3 5DS Nottingham
    British79146010001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DMX MUSIC UK LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Curtain Road
    EC2A 3BX London
    141-145
    England
    06 abr 2016
    Curtain Road
    EC2A 3BX London
    141-145
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro07304897
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene DMX MUSIC UK LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 11 jun 2010
    Entregado el 17 jun 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of its properties,equipment,securities,securities systems rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Montreal (As Agent for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 17 jun 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 10 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 04 abr 2006
    Entregado el 18 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each of the obligor's to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Silver Point Finance Llc ("Security Trustee")
    Transacciones
    • 18 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 20 jul 2000
    Entregado el 25 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 25 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Share pledge
    Creado el 21 ene 1999
    Entregado el 09 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company, aei music network inc., Reditune gmbh or reditune achtergrondmuzierk en reklame B.V. (the borrowers") to the chargees under the terms of the pledge, the credit agreement dated 31ST december 1998 and any other loan agreement
    Breve descripción
    1. 70 shares of nlg 100 each number from 256 to 325 (inclusive) in aei reditune music B.V. and 2. all existing and future securities cash and non cash dividends an other property at any time and from time to time received receivable or otherwise distributed in respect to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • U.S. Bank National Association(In It's Capacity as Agent for Itself, First Union National Bank, U.S. Bank and Any Subsequent Additional LENDERS0
    Transacciones
    • 09 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 03 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Share pledge
    Creado el 18 ene 1999
    Entregado el 27 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any remaining part of the purchase price of the shares (as defined) together with any interest and penalties due thereon
    Breve descripción
    175 shares of nlg 100 each,numbered from 326 to 500 in aei/reditune music B.V. with all rights to receive dividends in respect of the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gooi En Vechtstreek Beheer B.V.
    Transacciones
    • 27 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 03 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene DMX MUSIC UK LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    17 mar 2019Fecha de disolución
    27 nov 2017Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Kevin Brown
    3 New Street
    YO1 8RA York
    Profesional
    3 New Street
    YO1 8RA York

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0