DMX MUSIC UK LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | DMX MUSIC UK LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02802596 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DMX MUSIC UK LTD?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra DMX MUSIC UK LTD?
| Dirección de la sede social | 3 New Street YO1 8RA York |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DMX MUSIC UK LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AEI MUSIC NETWORK LIMITED | 17 ago 1998 | 17 ago 1998 |
| AEI MUSIC LIMITED | 15 jun 1993 | 15 jun 1993 |
| FC1038 LIMITED | 23 mar 1993 | 23 mar 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DMX MUSIC UK LTD?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DMX MUSIC UK LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 16 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de West House 46 High Street Orpington Kent BR6 0JQ England a 3 New Street York YO1 8RA el 08 ene 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 9 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital el 01 dic 2017
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Kenneth Eissing como director el 25 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Claude Nahon como director el 25 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Caroline Sarah Trenter como director el 25 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Forest Lodge Westerham Road Keston Kent BR2 6HE a West House 46 High Street Orpington Kent BR6 0JQ el 11 sept 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Randal Joseph Rudniski como director el 16 jun 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Caroline Sarah Trenter como secretario el 12 sept 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Anthony D'cruz como secretario el 12 sept 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DMX MUSIC UK LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENTER, Caroline Sarah | Secretario | New Street YO1 8RA York 3 | 190910400001 | |||||||
| EISSING, Kenneth H. | Director | New Street YO1 8RA York 3 | United States | American | 205614280001 | |||||
| TRENTER, Caroline Sarah | Director | New Street YO1 8RA York 3 | England | British | 205489350001 | |||||
| D'CRUZ, Richard Anthony | Secretario | Forest Lodge Westerham Road BR2 6HE Keston Kent | 149609350001 | |||||||
| HAZELWOOD, Sarah Jane | Secretario | 20 Goldsmid Road TN9 2BX Tonbridge Kent | British | 55607950002 | ||||||
| MILES, Sallie Ann | Secretario | 2632 North West 87th Street Seattle Washington 98117 FOREIGN Usa | American | 36134210001 | ||||||
| SAUNDERS, David | Secretario | 30 Swain Road ME8 0SN Gillingham Kent | British | 76995460001 | ||||||
| TRENTER, Caroline Sarah Louise | Secretario | Serpentine Road TN13 3XP Sevenoaks 4 Kent | British | 118124720002 | ||||||
| YOUNGMAN, Kenneth John | Secretario | 40 The Green Southgate N14 6EN London | British | 76405430001 | ||||||
| LEGIST SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London | 900006080001 | |||||||
| AYRAULT, Arthur Delancey | Director | 1730 Evergreen Place FOREIGN Seattle Wa 98122 Usa | American | 81221650001 | ||||||
| BAILEY, Mark Alexander Marshall | Director | 17 Austenway Chalfont St Peter SL9 8NN Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 108294640001 | |||||
| BAXTER, Robert David | Director | 13254 La Quinta St La Mirada California Ca90638 Usa | American | 80919590001 | ||||||
| BECKER, William Allen | Director | Treetops Shoppenhangers Road SL6 2PZ Maidenhead Berkshire Usa | American | 49500030001 | ||||||
| BEESLEY, Adrian Francis Mark | Director | 6 Woodview Close Kingston Vale SW15 3RL London | British | 54801580002 | ||||||
| CAREY, Mark Andrew | Director | Manor Cottage South Street OX11 9PX Blewbury Oxfordshire | United Kingdom | British | 118790790001 | |||||
| CLARK, Michael | Director | 40 Glen View Road Old Greenhill S8 7SF Sheffield South Yorkshire | British | 57851340001 | ||||||
| DAHL, Daniel John | Director | 21534 S E 37th Street WA98027 Issaquah Washington Usa | American | 36714740001 | ||||||
| GRABER, Stuart | Director | 15 Heathgate NW11 7AR London | United Kingdom | American | 71042580001 | |||||
| GUJRAL, Ben | Director | Forest Lodge Westerham Road BR2 6HE Keston Kent | United Kingdom | British | 117933240001 | |||||
| HOGAN, William Robert | Director | Flat 7 Sandringham Court 37 The Avenue BR3 5EE Beckenham Kent | American | 50882900001 | ||||||
| MALONE, Michael James | Director | 900 East Pine Street Seattle 98122 Washington Usa | Usa | 36257490001 | ||||||
| MATYSIK, Michael Karl | Director | 23627 74th Avenue West 98026 Edmonds Wa Usa | American | 51123840001 | ||||||
| MENSINK, Maurice William | Director | Zwaluwlaan 100 1403 Bl Bussum FOREIGN Netherlands | Dutch | 42722210001 | ||||||
| MOUNTBATTEN, Ivar Alexander Michael, Lord | Director | Bridwell Park Uffculme EX15 3BU Cullompton Devon | England | British | 46140520002 | |||||
| NAHON, Claude | Director | 46 High Street BR6 0JQ Orpington West House Kent England | France | French | 188551320001 | |||||
| PATRICK, Jonathan | Director | North End RG20 0BA Newbury Ansell House Berkshire | England | British | 133718670001 | |||||
| PROBERT, Gregory Lee | Director | 1440 St Albans Road San Marino, California Ca 91108 United States | United States | American | 56332270001 | |||||
| RING, Christopher David | Director | Crown Cottage Groombridge Hill Groombridge TN3 9QE Tunbridge Wells Kent | British | 45083070001 | ||||||
| ROBERTS, David Wynne | Director | Wayside House Shinfield Road Shinfield RG2 9BE Reading Berkshire | British | 81016310001 | ||||||
| RUDNISKI, Randal Joseph | Director | Forest Lodge Westerham Road BR2 6HE Keston Kent | United States | Canadian | 182919080001 | |||||
| SKINNER, Paul W | Director | 3821 East Pine Street Seattle Washington 98112 Usa | American | 46468770001 | ||||||
| STEAD, Paul | Director | 65 Slayley View Road Barlborough S43 4UQ Chesterfield Derbyshire | United Kingdom | British | 67613040001 | |||||
| VON STAUFFENBERG, Philippe Friedrich Maria De Spiritu Sanctu Schenk Graf | Director | 120 Castelnau SW13 9EU London | England | British,German | 71123620001 | |||||
| WHEELHOUSE, Kevin Paul | Director | 25 Carisbrooke Drive NG3 5DS Nottingham | British | 79146010001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DMX MUSIC UK LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mood Media Uk Holdings Ltd | 06 abr 2016 | Curtain Road EC2A 3BX London 141-145 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene DMX MUSIC UK LTD alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creado el 11 jun 2010 Entregado el 17 jun 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All of its properties,equipment,securities,securities systems rights see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 abr 2006 Entregado el 18 abr 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each of the obligor's to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 20 jul 2000 Entregado el 25 jul 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Share pledge | Creado el 21 ene 1999 Entregado el 09 feb 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company, aei music network inc., Reditune gmbh or reditune achtergrondmuzierk en reklame B.V. (the borrowers") to the chargees under the terms of the pledge, the credit agreement dated 31ST december 1998 and any other loan agreement | |
Breve descripción 1. 70 shares of nlg 100 each number from 256 to 325 (inclusive) in aei reditune music B.V. and 2. all existing and future securities cash and non cash dividends an other property at any time and from time to time received receivable or otherwise distributed in respect to the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Share pledge | Creado el 18 ene 1999 Entregado el 27 ene 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and any remaining part of the purchase price of the shares (as defined) together with any interest and penalties due thereon | |
Breve descripción 175 shares of nlg 100 each,numbered from 326 to 500 in aei/reditune music B.V. with all rights to receive dividends in respect of the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene DMX MUSIC UK LTD algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0