HEVERTECH LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHEVERTECH LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02803522
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HEVERTECH LIMITED?

    • Instalación eléctrica (43210) / Construcción
    • Instalación de fontanería, calefacción y aire acondicionado (43220) / Construcción
    • Actividades combinadas de apoyo a instalaciones (81100) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra HEVERTECH LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Resolution House
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HEVERTECH LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2020
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2021
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HEVERTECH LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta25 mar 2021
    Próxima declaración de confirmación vence06 may 2021
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta25 mar 2020
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HEVERTECH LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 12 abr 2025

    20 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 12 abr 2024

    34 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 12 abr 2023

    32 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 12 abr 2022

    22 páginasLIQ03

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    25 páginasAM22

    Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA

    14 páginasAM02

    Informe de progreso del administrador

    24 páginasAM10

    Resultado de la reunión de acreedores

    36 páginasAM07

    Declaración de la propuesta del administrador

    41 páginasAM03

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 2 Treefield Industrial Estate, Gelderd Road Leeds West Yorkshire LS27 7JU a Resolution House 12 Mill Hill Leeds LS1 5DQ el 28 may 2020

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    3 páginasAM01

    Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    10 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christopher Gordon James como director el 14 dic 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Stuart Sinclair Reid como director el 15 sept 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 25 mar 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    9 páginasAA

    Nombramiento de Mr Christopher Gordon James como director el 17 ago 2015

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de HEVERTECH LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    AGAR, Matthew
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    Secretario
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    162087010001
    AGAR, Matthew
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    Director
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    EnglandBritishCompany Director111220500001
    LINCOLN, Kevin
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    Director
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    EnglandBritishCompany Director64100240001
    WILLIAMS, Gary
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    Director
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    EnglandBritishElectrical Engineer207402290001
    ROPER, Peter Colin
    56 Woodcross
    Morley
    LS27 9HU Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    56 Woodcross
    Morley
    LS27 9HU Leeds
    West Yorkshire
    BritishProject Engineer34397660001
    SYERS, Duncan Sinclair
    Paddocks
    Harewood Road Collingham
    LS22 5BY Wetherby
    West Yorkshire
    Secretario
    Paddocks
    Harewood Road Collingham
    LS22 5BY Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector95929170001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secretario designado corporativo
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    CORKHILL, Christopher John
    Gateways
    The Avenue Collingham
    LS22 5BU Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    Gateways
    The Avenue Collingham
    LS22 5BU Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector95928330001
    DAVISON, Keith
    8 Birch Grove
    Woodlands Road
    WF17 0RQ Batley
    West Yorkshire
    Director
    8 Birch Grove
    Woodlands Road
    WF17 0RQ Batley
    West Yorkshire
    BritishContracts Engineer33627310002
    HORKAN, David
    Unit 2 Treefield Industrial
    Estate, Gelderd Road
    LS27 7JU Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Unit 2 Treefield Industrial
    Estate, Gelderd Road
    LS27 7JU Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishElectrical Engineer87624380001
    HORKAN, David
    50 Station Road
    Scholes
    LS15 4BT Leeds
    Yorkshire
    Director
    50 Station Road
    Scholes
    LS15 4BT Leeds
    Yorkshire
    EnglandBritishElectrical Engineer87624380001
    HUSSEY, John Arthur
    50 Gledhow Wood Avenue
    LS8 1NY Leeds
    Director
    50 Gledhow Wood Avenue
    LS8 1NY Leeds
    BritishHeating & Ventilation Engineer61523710001
    JAMES, Christopher Gordon
    Unit 2 Treefield Industrial
    Estate, Gelderd Road
    LS27 7JU Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Unit 2 Treefield Industrial
    Estate, Gelderd Road
    LS27 7JU Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishElectrical Engineer207402390001
    LAYCOCK, George
    The Knoll
    West Wells Road
    WF5 8PH Ossett
    West Yorkshire
    Director
    The Knoll
    West Wells Road
    WF5 8PH Ossett
    West Yorkshire
    BritishTechnical Manager33627320001
    LODGE, Jared Stephen
    Sandwath Drive
    LS22 9US Church Fenton
    71
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Sandwath Drive
    LS22 9US Church Fenton
    71
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director131270010001
    METCALFE, Paul Anthony
    85 Coppice Wood Avenue
    Yeadon
    LS19 7LQ Leeds
    West Yorkshire
    Director
    85 Coppice Wood Avenue
    Yeadon
    LS19 7LQ Leeds
    West Yorkshire
    BritishService Manager44049640001
    REID, Stuart Sinclair
    Unit 2 Treefield Industrial
    Estate, Gelderd Road
    LS27 7JU Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Unit 2 Treefield Industrial
    Estate, Gelderd Road
    LS27 7JU Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishMechanical Engineer177629360001
    ROPER, Peter Colin
    56 Woodcross
    Morley
    LS27 9HU Leeds
    West Yorkshire
    Director
    56 Woodcross
    Morley
    LS27 9HU Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director34397660001
    SYERS, Duncan Sinclair
    Paddocks
    Harewood Road Collingham
    LS22 5BY Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    Paddocks
    Harewood Road Collingham
    LS22 5BY Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector95929170001
    WALTON, Simon
    20 Braeburn Close
    Maltby
    S66 8SR Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    20 Braeburn Close
    Maltby
    S66 8SR Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director118684830001
    WINN, John Marshall
    Cedar Court
    169 Scotchman Lane
    LS27 0NY Morley
    Yorkshire
    Director
    Cedar Court
    169 Scotchman Lane
    LS27 0NY Morley
    Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director20893240001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Director designado corporativo
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HEVERTECH LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Kevin Lincoln
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    06 abr 2016
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    Mr Matthew Agar
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    06 abr 2016
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Resolution House
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene HEVERTECH LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 25 abr 2012
    Entregado el 27 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Bank)
    Transacciones
    • 27 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 12 jun 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 28 oct 2011
    Entregado el 01 nov 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Unit 2 treefield industrial estate gildersome leeds fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Duncan Syers and Christopher Corkhill
    Transacciones
    • 01 nov 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 13 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 15 dic 2010
    Entregado el 29 dic 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being. The company shall not be at liberty without the previous consent in writing of northern bank limited to create any mortgage or charge or confer any lien on its assets or any part thereof or to sell or deal with its book or other debts or securities for money otherwise than for the purpsoe of getting in and realising the same in the ordinary way of business.
    Personas con derecho
    • Northern Bank Limited
    Transacciones
    • 29 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 24 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 27 feb 2004
    Entregado el 06 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property known as bath house, 36 zoar street, morley, leeds t/no WYK14238. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 feb 2004
    Entregado el 06 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 27 oct 2003
    Entregado el 30 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    36 zoar street, morley, leeds, west yorkshire t/n WYK14238. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 30 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 17 jul 1998
    Entregado el 04 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    36 zoar street morley leeds west yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 01 ago 1995
    Entregado el 09 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene HEVERTECH LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 abr 2020Inicio de la administración
    13 abr 2021Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Michael Chamberlain
    Chamberlain & Co Resolution House
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Chamberlain & Co Resolution House
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    West Yorkshire
    Gareth David Peckett
    Resolution House 12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Profesional
    Resolution House 12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    2
    FechaTipo
    13 abr 2021Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Michael Chamberlain
    Chamberlain & Co Resolution House
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Chamberlain & Co Resolution House
    12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    West Yorkshire
    Gareth David Peckett
    Resolution House 12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds
    Profesional
    Resolution House 12 Mill Hill
    LS1 5DQ Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0