THE PAUL BEVAN CANCER FOUNDATION

THE PAUL BEVAN CANCER FOUNDATION

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE PAUL BEVAN CANCER FOUNDATION
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 02807079
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE PAUL BEVAN CANCER FOUNDATION?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra THE PAUL BEVAN CANCER FOUNDATION?

    Dirección de la sede social
    Thames Hospice
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE PAUL BEVAN CANCER FOUNDATION?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2025
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE PAUL BEVAN CANCER FOUNDATION?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta06 abr 2026
    Próxima declaración de confirmación vence20 abr 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta06 abr 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE PAUL BEVAN CANCER FOUNDATION?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 06 abr 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Janet King como director el 23 sept 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Jonathan Keith Toohey como director el 23 sept 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andy Francis Yuk Ho Ka como director el 23 sept 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2024

    3 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Christopher Grant Aitken el 23 sept 2024

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Catherine Mclaughlin como director el 23 sept 2024

    1 páginasTM01

    Notification de Thames Hospice en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    1 páginasPSC03

    Cese del nombramiento de Tracey Talbot como secretario el 07 jun 2024

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Philip Oldfield como secretario el 07 jun 2024

    2 páginasAP03

    Declaración de confirmación presentada el 06 abr 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Christopher Grant Aitken como director el 09 feb 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Catherine Mclaughlin como director el 03 oct 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Deborah Jane Raven como director el 23 sept 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Jones como director el 03 oct 2022

    1 páginasTM01

    Cessation de Debbie Raven en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 sept 2022

    1 páginasPSC07

    Cessation de Jonathan Jones en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 oct 2022

    1 páginasPSC07

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ruth Bartholomew como secretario el 22 abr 2021

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Tracey Talbot como secretario el 22 abr 2021

    2 páginasAP03

    Declaración de confirmación presentada el 06 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de THE PAUL BEVAN CANCER FOUNDATION?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OLDFIELD, Philip
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    Secretario
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    323862140001
    AITKEN, Christopher Grant
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    Director
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    EnglandScottishRetired99690860002
    KING, Janet
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    Director
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    EnglandBritishDirector71720710001
    TOOHEY, Jonathan Keith
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    Director
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    EnglandIrishAccountant328116980001
    ANDERSON, Gordon Scott
    Craigmyle
    6 Grant Walk
    SL5 9TT Ascot
    Berkshire
    Secretario
    Craigmyle
    6 Grant Walk
    SL5 9TT Ascot
    Berkshire
    British63473060001
    BARTHOLOMEW, Ruth
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    Secretario
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    193563340001
    BARTON, Sarah Louise
    c/o Thames Hospicecare
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Pine Lodge
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Thames Hospicecare
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Pine Lodge
    Berkshire
    United Kingdom
    180232120001
    COLQUHOUN, William
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Pine Lodge
    Berkshire
    Secretario
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Pine Lodge
    Berkshire
    British148517610001
    EGGLESTON, Gordon
    Moss Hill
    Fishers Wood
    SL5 0JF Ascot
    Berkshire
    Secretario
    Moss Hill
    Fishers Wood
    SL5 0JF Ascot
    Berkshire
    British67046250001
    HAYMAN, Pauline Anne
    9 Bradshaw Close
    SL4 5PS Windsor
    Berkshire
    Secretario
    9 Bradshaw Close
    SL4 5PS Windsor
    Berkshire
    BritishFinance Manager102455780001
    MOSS, Geoffrey
    31 Huntsmans Meadow
    SL5 7PF Ascot
    Berkshire
    Secretario
    31 Huntsmans Meadow
    SL5 7PF Ascot
    Berkshire
    British33420430003
    TALBOT, Tracey
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    Secretario
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    282377320001
    TURNER, Alan
    69 Sutherland Chase
    SL5 8TE Ascot
    Berkshire
    Secretario
    69 Sutherland Chase
    SL5 8TE Ascot
    Berkshire
    BritishChartered Secretary46320390001
    ANDERSON, Gordon Scott
    Craigmyle
    6 Grant Walk
    SL5 9TT Ascot
    Berkshire
    Director
    Craigmyle
    6 Grant Walk
    SL5 9TT Ascot
    Berkshire
    EnglandBritishRetired63473060001
    BENCE, Brian Jeffery
    Tanglewood
    130 Blackmoor Wood
    SL5 8EN Ascot
    Berkshire
    Director
    Tanglewood
    130 Blackmoor Wood
    SL5 8EN Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishSelf Employed Computer Consult102456050001
    CHALLIS, Clive Eric
    2 Dene Close
    RG12 2JF Bracknell
    Berkshire
    Director
    2 Dene Close
    RG12 2JF Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritishRetired11913600001
    COOK, Geoffrey William, Dr
    Pooh Corner
    Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    Director
    Pooh Corner
    Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    BritishRetired33420420001
    COPPOCK, Kenneth Francis
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Thames Hospice
    Berkshire
    England
    Director
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Thames Hospice
    Berkshire
    England
    EnglandBritishRetired Finance Director78528960003
    DAVIS, Norman
    Windle Gate Ballencrieff Road
    Sunningdale
    SL5 9RA Ascot
    Berkshire
    Director
    Windle Gate Ballencrieff Road
    Sunningdale
    SL5 9RA Ascot
    Berkshire
    AustralianRetired18820440001
    DIGGINS, James Edward
    Swinley Road Coronation Road
    SL5 9LL Ascot
    Berkshire
    Director
    Swinley Road Coronation Road
    SL5 9LL Ascot
    Berkshire
    BritishRetired41371680001
    DILLON, Stella
    31 Glebewood
    RG12 3SD Bracknell
    Berkshire
    Director
    31 Glebewood
    RG12 3SD Bracknell
    Berkshire
    BritishMacmillan Nurse33420410001
    EDWARDS, Antony William
    The Bungalow
    Poplars Farm Crouch Lane
    SL4 4TL Winkfield
    Berkshire
    Director
    The Bungalow
    Poplars Farm Crouch Lane
    SL4 4TL Winkfield
    Berkshire
    BritishChartered Surveyor77351570003
    EGGLESTON, Gordon
    Moss Hill
    Fishers Wood
    SL5 0JF Ascot
    Berkshire
    Director
    Moss Hill
    Fishers Wood
    SL5 0JF Ascot
    Berkshire
    BritishRetired67046250001
    FURNESS, Robert Harvey Scott, Dr
    The Manse
    High Street
    SL5 0NG Sunningdale
    Berkshire
    Director
    The Manse
    High Street
    SL5 0NG Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritishMedical Practitioner89136520001
    GALPIN, Brian John Francis, His Honour
    St Bruno House
    Charters Road
    SL5 9QB Sunningdale
    Berkshire
    Director
    St Bruno House
    Charters Road
    SL5 9QB Sunningdale
    Berkshire
    BritishRetired33420370001
    GOSS, Richard
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Thames Hospice
    Berkshire
    England
    Director
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Thames Hospice
    Berkshire
    England
    EnglandBritishRetired140643620002
    HICKS, Thomas Peter
    15 Redwood Drive
    SL5 0LW Ascot
    Berkshire
    Director
    15 Redwood Drive
    SL5 0LW Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Executive43934940002
    HICKS, Thomas Peter
    13 Woodend Drive
    SL5 9BD South Ascot
    Berkshire
    Director
    13 Woodend Drive
    SL5 9BD South Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Executive43934940001
    HODGSON, George Cribbes
    Norcott
    Llanvair Drive
    SL5 9HS South Ascot
    Berks
    Director
    Norcott
    Llanvair Drive
    SL5 9HS South Ascot
    Berks
    EnglandEnglishRetired3624530001
    JONES, David Sebastian, The Rev
    The Vicarage Vicarage Gardens
    SL5 9DX Ascot
    Berkshire
    Director
    The Vicarage Vicarage Gardens
    SL5 9DX Ascot
    Berkshire
    BritishClerk In Holy Order44859490001
    JONES, Jonathan
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    Director
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    EnglandBritishRetired165724770001
    LANCEFIELD, Doreen
    30 Goldsmith Way
    Wellington Chase
    RG11 7QP Crowthorne
    Berkshire
    Director
    30 Goldsmith Way
    Wellington Chase
    RG11 7QP Crowthorne
    Berkshire
    BritishRetired45665890001
    LANCEFIELD, Doreen
    30 Goldsmith Way
    Wellington Chase
    RG11 7QP Crowthorne
    Berkshire
    Director
    30 Goldsmith Way
    Wellington Chase
    RG11 7QP Crowthorne
    Berkshire
    BritishVolunteer Co-Ordinater45665890001
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    c/o Thames Hospicecare
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Pine Lodge
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Thames Hospicecare
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Pine Lodge
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director34653220004
    MCLAUGHLIN, Catherine
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    Director
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    EnglandIrishCeo228526790001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de THE PAUL BEVAN CANCER FOUNDATION?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mrs Debbie Raven
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    09 oct 2017
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Jonathan Jones
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    06 abr 2016
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Kenneth Francis Coppock
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Thames Hospice
    Berkshire
    England
    06 abr 2016
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Thames Hospice
    Berkshire
    England
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Richard Goss
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Thames Hospice
    Berkshire
    England
    06 abr 2016
    Hatch Lane
    SL4 3RW Windsor
    Thames Hospice
    Berkshire
    England
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Thames Hospice
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    06 abr 2016
    Windsor Road
    SL6 2DN Maidenhead
    Thames Hospice
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    Autoridad legalUk
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0