MITIE SCOTGATE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MITIE SCOTGATE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02809256 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MITIE SCOTGATE LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra MITIE SCOTGATE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 30 Finsbury Square EC2A 1AG London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MITIE SCOTGATE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SCOTGATE ENGINEERING SERVICES LIMITED | 06 abr 1994 | 06 abr 1994 |
| SCOTGATE ELECTRICAL ENGINEERS LIMITED | 01 oct 1993 | 01 oct 1993 |
| DOREPATH LIMITED | 14 abr 1993 | 14 abr 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MITIE SCOTGATE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MITIE SCOTGATE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 9 páginas | LIQ13 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Level 12 the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Level 12 the Shard 32 London Bridge Street London England SE1 9SG England a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG el 07 ene 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Charles Kirkpatrick como director el 27 ago 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Matthew Robert Peacock como director el 26 ago 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Modification des détails de Mitie Environmental Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 nov 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Simon Charles Kirkpatrick el 30 ene 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Simon Charles Kirkpatrick como director el 30 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Idle como director el 29 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2019 | 12 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 170 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard John Blumberger como director el 18 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Matthew Idle como director el 18 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MITIE SCOTGATE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | 114537130001 | |||||||
| DICKINSON, Peter John Goddard | Director | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | England | British | 229653270003 | |||||
| PEACOCK, Matthew Robert | Director | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | England | British | 286359510001 | |||||
| HARVEY, Andrew Michael | Secretario | 2 High Street Morton PE10 0NR Bourne Lincolnshire | British | 36323380002 | ||||||
| ROSS, Corina Katherine | Secretario | Ainslie's Cottage 30b Belvedere, Lansdown BA1 5HR Bath Avon | British | 69836440002 | ||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| ACHESON, Colin Stewart | Director | 191 Sycamore Road GU14 6RQ Farnborough Hampshire | England | British | 48231890002 | |||||
| BARRATT, John Ernest | Director | Gorstage School Road, Broughton PE28 3AT Huntingdon Cambridgeshire | British | 81754480001 | ||||||
| BAXTER, Suzanne Claire | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 113058450002 | |||||
| BLUMBERGER, Richard John | Director | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | England | British | 137120140004 | |||||
| CLARKE, James Ian | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England | England | British | 135276530001 | |||||
| HARVEY, Andrew Michael | Director | 12 Main Street Tinwell PE9 3UD Rutland Lincolnshire | British | 36323380003 | ||||||
| HAWKE, Simon | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 193143080001 | |||||
| HOLLAND, Philip Jeffery | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | 177740210001 | |||||
| HORROCKS, Lee Craige | Director | Flat 9 Deveraux House, 2 Tewksbury Close EN4 8AX New Barnet | England | British | 121727990003 | |||||
| IDLE, Matthew | Director | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | United Kingdom | British | 254600670001 | |||||
| IRVINE, Ian Robert | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | 162709230001 | |||||
| KIRKPATRICK, Simon Charles | Director | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | England | British | 233739330001 | |||||
| LEO, Peter | Director | Alderlands House 55 Broadway Crowland PE6 0BH Peterborough Cambridgeshire | United Kingdom | British | 27966680001 | |||||
| MANLEY, Peter Arthur | Director | 24 Southfield Drive West Winch PE33 0PF Kings Lynn Norfolk | British | 70882040002 | ||||||
| MCENTAGGART, Kevin Anthony | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | Uk | British | 86481590001 | |||||
| MCGREGOR-SMITH, Ruby | Director | 8 Monarch Court The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol | United Kingdom | British | 39857280003 | |||||
| MOSLEY, Peter Frederick | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England | England | British | 74937260002 | |||||
| NEW, Andrew John | Director | 15 Laxton Drive Oundle PE8 5TW Peterborough | United Kingdom | British | 87319020001 | |||||
| PAYNE, Christopher Richard | Director | 8 Monarch Court The Brooms, Emersons Green BS16 7FH Bristol | England | British | 238065750001 | |||||
| PETTIFOR, Timothy John | Director | Treetops 47 Caxton End Eltisley PE19 4TJ Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British | 40366940001 | |||||
| REEDMAN, Paul Graham | Director | 1 Hall Close NN6 6AJ Naseby Northamptonshire | British | 86032260001 | ||||||
| ROSE, Sally Ann | Director | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | England | British | 326783960001 | |||||
| SMITH, Stuart Ashley | Director | 9 Back Lane Wicken CB7 5YL Ely Cambridgeshire | England | British | 86032150001 | |||||
| STEWART, Ian Reginald | Director | Lullingworth Stroud Road GL6 6UT Painswick Gloucestershire | England | British | 1517500002 | |||||
| STOKES, Richard Mark | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 85329460003 | |||||
| TELLING, David Malcolm | Director | Meeting House Farm Long Lane Wrington BS40 5SP Bristol | British | 15023940001 | ||||||
| TIVEY, Michael Anthony | Director | 8 Monarch Court The Brooms, Emersons Green BS16 7FH Bristol | United Kingdom | British | 37917060003 | |||||
| WOODWARD, Timothy Nigel | Director | 11 Chapel Street Crowland PE6 0AR Peterborough Lincolnshire | England | British | 86512360002 | |||||
| L & A REGISTRARS LIMITED | Director designado corporativo | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001440001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MITIE SCOTGATE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitie Dormant (No.2) Limited | 06 abr 2016 | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MITIE SCOTGATE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage deed | Creado el 23 ene 1998 Entregado el 29 ene 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property k/a scotgate house dukeshead werrington. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 13 oct 1995 Entregado el 17 oct 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Property k/a or being scotgate house dukesmead werrington peterborough PE4 6ZN t/n-CB107700. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Single debenture | Creado el 04 jul 1994 Entregado el 08 jul 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene MITIE SCOTGATE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0