SPRING RAM BATHROOMS LIMITED

SPRING RAM BATHROOMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSPRING RAM BATHROOMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02809899
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SPRING RAM BATHROOMS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra SPRING RAM BATHROOMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Po Box 572 Woodlands
    21 Roydsdale Way Euroway
    BD4 6SE Industrial Estate Bradford
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SPRING RAM BATHROOMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SPRING RAM BATHROOMS PLC20 ene 199920 ene 1999
    RAM BATHROOMS PLC16 abr 199316 abr 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SPRING RAM BATHROOMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 mar 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SPRING RAM BATHROOMS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SPRING RAM BATHROOMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Christopher Pearson como director el 26 nov 2014

    1 páginasTM01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Déclaration annuelle établie au 16 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 sept 2014

    Estado de capital el 19 sept 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cambio de datos del director The Spring Ram Corporation Limited el 06 feb 2014

    1 páginasCH02

    Cese del nombramiento de un director

    2 páginasTM01

    Cambio de datos del director The Spring Ram Corporation Plc el 22 mar 2013

    1 páginasCH02

    Cese del nombramiento de David Mackinnon como secretario

    2 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 mar 2013

    4 páginasAA

    Certificado de re-registro de Compañía Pública Limitada a Privada

    1 páginasCERT10

    Re-registro del Memorándum y Estatutos

    23 páginasMAR

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de re-registro

    RES02

    Re-registro de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada

    1 páginasRR02

    Déclaration annuelle établie au 16 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 jun 2013

    Estado de capital el 04 jun 2013

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2012 au 30 mar 2013

    3 páginasAA01

    legacy

    3 páginasMG02

    Cese del nombramiento de Philip White como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de The Spring Ram Corporation Plc como director

    2 páginasAP02

    Nombramiento de Mr Christopher Pearson como director

    2 páginasAP01

    legacy

    5 páginasMG01

    Déclaration annuelle établie au 16 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 oct 2011

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Mark Prince como director

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SPRING RAM BATHROOMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary27825440001
    EDWARDS, John
    Rectory View Pinfold Lane
    WF14 9JA Mirfield
    West Yorkshire
    Secretario
    Rectory View Pinfold Lane
    WF14 9JA Mirfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director3313700002
    MACKINNON, David Stuart
    4 Meadow Fold
    Uppermill
    OL3 6EZ Oldham
    Lancashire
    Secretario
    4 Meadow Fold
    Uppermill
    OL3 6EZ Oldham
    Lancashire
    British64869460001
    WEAVER, Paul
    34 High Street
    Farsley
    LS28 5LH Pudsey
    West Yorkshire
    Secretario
    34 High Street
    Farsley
    LS28 5LH Pudsey
    West Yorkshire
    British45193280001
    SIMCO COMPANY SERVICES LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    Secretario designado corporativo
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    900004040001
    ANDERSON, David Joseph
    58 Savile Park
    HX1 3EX Halifax
    West Yorkshire
    Director
    58 Savile Park
    HX1 3EX Halifax
    West Yorkshire
    BritishDirector39572630001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary27825440001
    BROWN, Stephen John
    Wharferise
    111 Weston Lane
    LS21 2DF Otley
    West Yorkshire
    Director
    Wharferise
    111 Weston Lane
    LS21 2DF Otley
    West Yorkshire
    BritishDirector70149030001
    CLARKE, Noel Christopher
    7 Packwood Court
    Bucknell Close
    B91 3SZ Solihull
    West Midlands
    Director
    7 Packwood Court
    Bucknell Close
    B91 3SZ Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director58258900001
    COX, Stephen John
    27 Briksdal Way
    Lostock
    BL6 4PQ Bolton
    Lancashire
    Director
    27 Briksdal Way
    Lostock
    BL6 4PQ Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector36679080002
    DEVINE, Donald Charles
    777 South Flagler Drive
    Suite 1100
    West Palm Beach
    Florida Fl33401-6102
    Usa
    Director
    777 South Flagler Drive
    Suite 1100
    West Palm Beach
    Florida Fl33401-6102
    Usa
    AmericanChief Executive Officer84975190004
    EDWARDS, John
    Rectory View Pinfold Lane
    WF14 9JA Mirfield
    West Yorkshire
    Director
    Rectory View Pinfold Lane
    WF14 9JA Mirfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director3313700002
    FLANNERY, Lisa
    28 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    28 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director69964220001
    HERRMANN, Paul Alan
    5336 Stonehurst Drive
    Martinez
    California
    Ca 94553
    Usa
    Director
    5336 Stonehurst Drive
    Martinez
    California
    Ca 94553
    Usa
    AmericanDirector72635630002
    JACUZZI, Roy A
    142 Silver Oak Terrace
    94563 Orinda
    California
    Director
    142 Silver Oak Terrace
    94563 Orinda
    California
    AmericanDirector38833370001
    LEAMAN, Peter Harry
    Snug House
    1 Snug Lane Hepworth
    HD9 1RP Huddersfield
    Director
    Snug House
    1 Snug Lane Hepworth
    HD9 1RP Huddersfield
    United KingdomBritishCompany Director76423940001
    MACKENZIE, Andrew Macgregor
    Stridings 33 Hazel Grove
    Greave
    OL13 9XT Bacup
    Lancashire
    Director
    Stridings 33 Hazel Grove
    Greave
    OL13 9XT Bacup
    Lancashire
    BritishCompany Director38695210001
    MACKINNON, David Stuart
    4 Meadow Fold
    Uppermill
    OL3 6EZ Oldham
    Lancashire
    Director
    4 Meadow Fold
    Uppermill
    OL3 6EZ Oldham
    Lancashire
    EnglandBritishAsst Company Secretary64869460001
    MORRISON, Neil Rowatt
    2 Tentergate Lane
    HG5 9BH Knaresborough
    North Yorkshire
    Director
    2 Tentergate Lane
    HG5 9BH Knaresborough
    North Yorkshire
    BritishDirector52834490001
    PARK, Jeffrey Bryan
    777 South Flagler Drive
    Suite 1100
    West Palm Beach
    Florida Fl33401-6102
    Usa
    Director
    777 South Flagler Drive
    Suite 1100
    West Palm Beach
    Florida Fl33401-6102
    Usa
    AmericanChief Financial Officer84975330003
    PEARSON, Christopher
    PO BOX 572 Woodlands
    21 Roydsdale Way Euroway
    BD4 6SE Industrial Estate Bradford
    West Yorkshire
    Director
    PO BOX 572 Woodlands
    21 Roydsdale Way Euroway
    BD4 6SE Industrial Estate Bradford
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector174624400001
    PRINCE, Mark Bramley
    Oak Cottage Leas Gardens
    Jackson Bridge
    HD9 1UG Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Oak Cottage Leas Gardens
    Jackson Bridge
    HD9 1UG Huddersfield
    West Yorkshire
    WalesWelshCompany Director50891570001
    RILEY, David
    Ryefield House School Lane
    Edgeworth
    BL7 0PR Bolton
    Lancashire
    Director
    Ryefield House School Lane
    Edgeworth
    BL7 0PR Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director33354610001
    ROONEY, William Thomas
    Treetops Northedge Lane
    Norwood Green
    HX8 3AG Halifax
    West Yorkshire
    Director
    Treetops Northedge Lane
    Norwood Green
    HX8 3AG Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director18244740001
    ROWE, Scott Lynn
    6509 Laurel Street
    Corona
    California 92880
    Usa
    Director
    6509 Laurel Street
    Corona
    California 92880
    Usa
    UsaTax Director122587970002
    SAXTON, Philip Anthony
    20 Springwater Avenue
    Holcombe Brook
    BL0 9RH Ramsbottom
    Lancashire
    Director
    20 Springwater Avenue
    Holcombe Brook
    BL0 9RH Ramsbottom
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director89642310001
    STUART, Paul Agnus
    10 Victoria Springs
    Holmfirth
    HD7 1NB Huddersfield
    West Yorkshsire
    Director
    10 Victoria Springs
    Holmfirth
    HD7 1NB Huddersfield
    West Yorkshsire
    BritishDirector39651570001
    SYKES, David Thomas
    The Old Rectory 80 Barnsley Road
    Upper Cumberworth
    HD8 8NN Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    The Old Rectory 80 Barnsley Road
    Upper Cumberworth
    HD8 8NN Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director61293790002
    TOWERS, Martin George
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    Director
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director36252860002
    TROTTER, Robin Hudson
    Carradale
    Hob Lane
    HX6 4LU Ripponden
    West Yorkshire
    Director
    Carradale
    Hob Lane
    HX6 4LU Ripponden
    West Yorkshire
    BritishCompany Director78730570001
    WALMSLEY, Linda Margaret
    3 Wilsden Hill
    Wilsden
    BD15 0BG Bradford
    West Yorkshire
    Director
    3 Wilsden Hill
    Wilsden
    BD15 0BG Bradford
    West Yorkshire
    BritishDirector28046830001
    WEAVER, Paul
    34 High Street
    Farsley
    LS28 5LH Pudsey
    West Yorkshire
    Director
    34 High Street
    Farsley
    LS28 5LH Pudsey
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary45193280001
    WHITE, Philip Charles
    Roydsdale Way
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SE Bradford
    Woodlands 21
    West Yorkshire
    Director
    Roydsdale Way
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SE Bradford
    Woodlands 21
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director112021740001
    WILD, Philip Anthony
    18 Old Kiln Lane
    Grotton
    OL4 5RZ Oldham
    Lancashire
    Director
    18 Old Kiln Lane
    Grotton
    OL4 5RZ Oldham
    Lancashire
    BritishDirector6039620002
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Director
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    BritishDirector47433990002

    ¿Tiene SPRING RAM BATHROOMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge of deposit
    Creado el 11 dic 2012
    Entregado el 17 dic 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit of £400,000 and all amounts in the future credit to account number 46976523 with the bank.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 30 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creado el 11 mar 1996
    Entregado el 26 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 sept 1993
    Entregado el 22 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 21 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0