AMERICAN PAN UK LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAMERICAN PAN UK LTD
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02826812
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AMERICAN PAN UK LTD?

    • fabricación de otros productos de metal n.c.o.p. (25990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra AMERICAN PAN UK LTD?

    Dirección de la sede social
    American Pan Uk Ltd Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AMERICAN PAN UK LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FBS PRESTIGE LIMITED01 sept 201501 sept 2015
    PRESTIGE INDUSTRIAL LIMITED25 feb 200225 feb 2002
    BI BAKEWARE LIMITED27 ene 200027 ene 2000
    PRESTIGE INDUSTRIAL LIMITED28 sept 199328 sept 1993
    DMWSL 127 LIMITED14 jun 199314 jun 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AMERICAN PAN UK LTD?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AMERICAN PAN UK LTD?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta31 dic 2026
    Próxima declaración de confirmación vence14 ene 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta31 dic 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AMERICAN PAN UK LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    replacement-filing-of-director-appointment-with-name

    3 páginasRP01AP01

    Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 31 dic 2024

    23 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    22 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    23 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Maclay Murray & Spens Llp como secretario el 26 nov 2018

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    23 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de One London Wall London Wall London EC2Y 5AB England a American Pan Uk Ltd Excalibur Way Irlam Manchester M44 5DL el 20 oct 2017

    1 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name18 oct 2017

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 04 oct 2017

    RES15

    Nombramiento de Mr Robert Bundy como director el 17 jul 2017

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    12 ene 2026Replaced A replacement AP01 was registered 12/01/2026 as the original contained an error

    Nombramiento de Mr William Bundy como director el 17 jul 2017

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de AMERICAN PAN UK LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BUNDY, Gilbert Ludwig
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    Director
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    United StatesAmerican236623540001
    BUNDY, Robert Alexander
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    Director
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    United StatesAmerican230829310001
    BUNDY, William
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    Director
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    United StatesAmerican236623590001
    BUNDY JR, Russell
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    Director
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    United StatesAmerican236623560001
    CASARIN, Mario
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    Director
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    American Pan Uk Ltd
    England
    BrazilBrazilian236590520001
    BEALE, Derek John
    166 Swallow Street
    SL0 0HR Iver
    Buckinghamshire
    Secretario
    166 Swallow Street
    SL0 0HR Iver
    Buckinghamshire
    British34336730001
    CUMINS, John David
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    England
    Secretario
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    England
    200560910001
    MILES, Tracy
    28 Teasel Way
    Claines
    WR3 7LD Worcester
    Worcestershire
    Secretario
    28 Teasel Way
    Claines
    WR3 7LD Worcester
    Worcestershire
    British67263360002
    WAIN, Stephen Gerrard
    17 Burton Road
    Twycross
    CV9 3PR Atherstone
    Warwickshire
    Secretario
    17 Burton Road
    Twycross
    CV9 3PR Atherstone
    Warwickshire
    British2167290001
    WELLS, Fergus
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British138481790001
    WELLS, Trevor Jesse
    The Hopleys
    Horringer
    IP29 5PX Bury St Edmunds
    Suffolk
    Secretario
    The Hopleys
    Horringer
    IP29 5PX Bury St Edmunds
    Suffolk
    British35485980001
    BI NOMINEES LIMITED
    Unit 1 First Avenue
    Maybrook Industrial Estate, Minworth
    B76 1BA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario corporativo
    Unit 1 First Avenue
    Maybrook Industrial Estate, Minworth
    B76 1BA Sutton Coldfield
    West Midlands
    103445180002
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Secretario designado corporativo
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Secretario corporativo
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSO300744
    119967690001
    BEALE, Derek John
    166 Swallow Street
    SL0 0HR Iver
    Buckinghamshire
    Director
    166 Swallow Street
    SL0 0HR Iver
    Buckinghamshire
    British34336730001
    BOGGILD, Leslie
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Director
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    United KingdomBritish122684110002
    CAMPBELL, Annette Jane
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    Fluorocarbon Buildings
    England
    Director
    Excalibur Way
    Irlam
    M44 5DL Manchester
    Fluorocarbon Buildings
    England
    EnglandNew Zealander193300980001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Director designado
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    DAWBER, Keith Thomas
    Acer Lodge 25 Highgale Gardens
    Lostock Hall
    PR5 5YT Preston
    Lancashire
    Director
    Acer Lodge 25 Highgale Gardens
    Lostock Hall
    PR5 5YT Preston
    Lancashire
    British68290430001
    DYKES, John Bryan
    13 Sydney Street
    SW3 6PU London
    Director
    13 Sydney Street
    SW3 6PU London
    British11595800001
    GARDNER, Anthony John
    Lilac Grove
    Beeston
    NG9 1PF Nottingham
    Fbs Prestige
    Director
    Lilac Grove
    Beeston
    NG9 1PF Nottingham
    Fbs Prestige
    United KingdomBritish91131610001
    GRAHAM, Alan Thomas
    42 Aspin Park Road
    HG5 8HG Knaresborough
    North Yorkshire
    Director
    42 Aspin Park Road
    HG5 8HG Knaresborough
    North Yorkshire
    British57864870001
    HAYES, Stephen Hedley
    1 Hodgetts Drive
    Hayley Green
    B63 1ET Halesowen
    West Midlands
    Director
    1 Hodgetts Drive
    Hayley Green
    B63 1ET Halesowen
    West Midlands
    British16415620002
    HERRING, Michael Thomas Arthur
    Kingslodge Manor Farm
    Apethorpe
    PE8 5DP Peterborough
    Cambridgeshire
    Director
    Kingslodge Manor Farm
    Apethorpe
    PE8 5DP Peterborough
    Cambridgeshire
    British8795230001
    LAWRENCE, Martin Proom
    The Walnuts 61 Bridge Street
    Kings Cliffe
    PE8 6XH Peterborough
    Cambridshire
    Director
    The Walnuts 61 Bridge Street
    Kings Cliffe
    PE8 6XH Peterborough
    Cambridshire
    British56005840001
    RIDING, Suzanne
    2 Keepers Wood Way
    Catterall
    PR3 1TP Preston
    Lancashire
    Director
    2 Keepers Wood Way
    Catterall
    PR3 1TP Preston
    Lancashire
    British107862560004
    SEDGHI, Bijan Martin
    Sandalls
    944 Warwick Road
    B91 3HW Solihull
    West Midlands
    Director
    Sandalls
    944 Warwick Road
    B91 3HW Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish109774110001
    SHARP, William Martin
    Lilac Grove
    Beeston
    NG9 1PF Nottingham
    Fbs Prestige
    Director
    Lilac Grove
    Beeston
    NG9 1PF Nottingham
    Fbs Prestige
    RomaniaBritish166046260001
    SLATER, Peter
    34 Hillcrest Road
    Langho
    BB6 8EP Blackburn
    Lancashire
    Director
    34 Hillcrest Road
    Langho
    BB6 8EP Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish68241820001
    SPENCER, Graham
    577 Brunshaw Road
    BB10 4HS Burnley
    Lancashire
    Director
    577 Brunshaw Road
    BB10 4HS Burnley
    Lancashire
    British35384160001
    STEWART, Glen
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Director
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    EnglandBritish193756640001
    TAYLOR, Merrick Wentworth
    The Stables
    Old Milverton Lane Old Milverton
    CV32 6SA Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    The Stables
    Old Milverton Lane Old Milverton
    CV32 6SA Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish34255090001
    WAIN, Stephen Gerrard
    The Nook 35 Main Street
    Norton Juxta Twycross
    CV9 3QA Atherstone
    Warwickshire
    Director
    The Nook 35 Main Street
    Norton Juxta Twycross
    CV9 3QA Atherstone
    Warwickshire
    United KingdomBritish2167290002
    WELLS, Fergus
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Director
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    EnglandBritish200561120001
    WELLS, Trevor Jesse
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    Director
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One London Wall
    England
    United KingdomBritish35485980001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de AMERICAN PAN UK LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    England
    17 jul 2017
    Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro10757306
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    England
    06 abr 2016
    Caxton Hill
    SG13 7NH Hertford
    Fluorocarbon House
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05847899
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0