BON BON BUDDIES LIMITED

BON BON BUDDIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBON BON BUDDIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02827349
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BON BON BUDDIES LIMITED?

    • Comercio al por mayor de azúcar y chocolate y confitería de azúcar (46360) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra BON BON BUDDIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Old Exchange 234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    Essex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BON BON BUDDIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PACKATEERS LIMITED15 jun 199315 jun 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BON BON BUDDIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BON BON BUDDIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    20 páginasLIQ14

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Destitución del liquidador por orden judicial

    28 páginasLIQ10

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 nov 2021

    20 páginasLIQ03

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 30 nov 2020

    LRESEX

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    11 páginasCVA4

    Domicilio social registrado cambiado de Suite 5a 5a Quest House, St Mellons Business Park Cardiff CF3 0EY United Kingdom a The Old Exchange 234 Southchurch Road Southend-on-Sea Essex SS1 2EG el 14 dic 2020

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Declaración de asuntos

    10 páginasLIQ02

    Cancelación total de la carga 10

    4 páginasMR04

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2020

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2019

    24 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 29 abr 2019 au 28 abr 2019

    1 páginasAA01

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2019 au 29 abr 2019

    1 páginasAA01

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 14 oct 2019

    10 páginasCVA3

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2018

    31 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 10

    6 páginasMR05

    Cancelación total de la carga 11

    5 páginasMR04

    Domicilio social registrado cambiado de One Foxes Lane Oakdale Business Park Blackwood South Wales NP12 4AB a Suite 5a 5a Quest House, St Mellons Business Park Cardiff CF3 0EY el 31 ene 2019

    1 páginasAD01

    Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor

    5 páginasCVA1

    Cese del nombramiento de Justin Paul Thomas como director el 13 sept 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Joanne Yvonne Manfield como director el 19 jul 2018

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de BON BON BUDDIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOWARTH, Christopher Stuart
    Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    The Old Exchange 234
    Essex
    Director
    Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    The Old Exchange 234
    Essex
    MaltaBritish34972700005
    CARR, Timothy James
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Secretario
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    British195790700001
    DAVIES, Geoffrey Clive
    81 Lake Road West
    Roath Park
    CF23 5PH Cardiff
    Secretario
    81 Lake Road West
    Roath Park
    CF23 5PH Cardiff
    British30472530002
    HOWARTH, Christopher Stuart
    Pont Gaer
    Tretower
    NP8 1SB Crickhowell
    Powys
    Secretario
    Pont Gaer
    Tretower
    NP8 1SB Crickhowell
    Powys
    British34972700001
    KNOWLES, Mark Henry
    3 Rhuddlan Close
    NP10 8QU Newport
    Gwent
    Secretario
    3 Rhuddlan Close
    NP10 8QU Newport
    Gwent
    British80799750001
    ZAMMIT, Ronald Charles
    Dartington Drive
    Pontprennau
    CF23 8SA Cardiff
    28
    South Glamorgan
    United Kingdom
    Secretario
    Dartington Drive
    Pontprennau
    CF23 8SA Cardiff
    28
    South Glamorgan
    United Kingdom
    British134812430001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    CARR, Timothy James
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Director
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    United KingdomBritish195790700001
    CAWDELL, Duncan
    4 Silure Way
    Langstone
    NP18 2NU Newport
    Gwent
    Director
    4 Silure Way
    Langstone
    NP18 2NU Newport
    Gwent
    British98220360001
    DAVIES, Peter Donald
    42 Elm Road
    East Sheen
    SW14 7JQ London
    Director
    42 Elm Road
    East Sheen
    SW14 7JQ London
    British46493680001
    DYER, Graham Paul
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Director
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    United KingdomBritish125487800001
    HOWARTH, Albert Thomas
    18 Kooringa
    CR6 9JP Warlingham
    Surrey
    Director
    18 Kooringa
    CR6 9JP Warlingham
    Surrey
    British36989900001
    HOWARTH, Pauline June
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Director
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    United KingdomBritish43796710001
    KNOWLES, Mark Henry
    3 Rhuddlan Close
    NP10 8QU Newport
    Gwent
    Director
    3 Rhuddlan Close
    NP10 8QU Newport
    Gwent
    British80799750001
    KURSAR, Ivan
    3 St Anns Place
    BA1 2BJ Bath
    Avon
    Director
    3 St Anns Place
    BA1 2BJ Bath
    Avon
    British29533070001
    MANFIELD, Joanne Yvonne
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Director
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    WalesBritish198672640001
    MILES, Stephen Anthony
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Director
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    WalesWelsh67332510001
    MONK, Paul John
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    Director
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    British71562530002
    MONK, Paul John
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    Director
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    British71562530002
    SUTHERLAND, Martin
    Red House
    Earlswood
    NP16 6AW Chepstow
    Gwent
    Director
    Red House
    Earlswood
    NP16 6AW Chepstow
    Gwent
    UkBritish190607410001
    THOMAS, Justin Paul
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    Director
    Foxes Lane
    Oakdale Business Park
    NP12 4AB Blackwood
    One
    South Wales
    WalesBritish183392850001
    TILLEY, Barry Thomas William
    Pheasants Seymour Plain
    SL7 3DA Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    Pheasants Seymour Plain
    SL7 3DA Marlow
    Buckinghamshire
    British45959380001
    TOMS, Kevin Paul
    Midsummer
    19 Delamare Way
    OX2 9HZ Oxford
    Oxfordshire
    Director
    Midsummer
    19 Delamare Way
    OX2 9HZ Oxford
    Oxfordshire
    British67332780001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BON BON BUDDIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Christopher Stuart Howarth
    Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    The Old Exchange 234
    Essex
    06 abr 2016
    Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    The Old Exchange 234
    Essex
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Malta
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene BON BON BUDDIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    Creado el 07 oct 2011
    Entregado el 11 oct 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transacciones
    • 11 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 01 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 28 jul 2011
    Entregado el 04 ago 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 04 ago 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 09 mar 2019Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 16 nov 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge of deposit
    Creado el 24 nov 2004
    Entregado el 30 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account designation 22120568 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 29 dic 2003
    Entregado el 06 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creado el 24 jun 2003
    Entregado el 24 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 24 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of shares
    Creado el 21 jul 2000
    Entregado el 28 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Breve descripción
    The shares together with all dividends and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 28 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creado el 21 jul 2000
    Entregado el 28 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Breve descripción
    The shares together with all dividends or other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 28 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 jul 2000
    Entregado el 28 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 28 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    All assets debenture
    Creado el 31 ago 1999
    Entregado el 14 sept 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • G E Capital Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 14 sept 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over book debts
    Creado el 11 jul 1994
    Entregado el 16 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or in connection with a financing agreement (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 16 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 12 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 06 dic 1993
    Entregado el 14 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 14 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BON BON BUDDIES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 oct 2018Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    14 dic 2020Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Eric Walls
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    Profesional
    C12 Marquis Court Marquis Way
    Team Valley
    NE11 0RU Gateshead
    2
    FechaTipo
    30 nov 2020Inicio de la liquidación
    20 abr 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Louise Donna Baxter
    Begbies Traynor (Central) Llp The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Profesional
    Begbies Traynor (Central) Llp The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Lloyd Christopher Biscoe
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend-On-Sea Essex
    Profesional
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend-On-Sea Essex
    Dominik Thiel-Czerwinke
    The Old Exchange 234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Profesional
    The Old Exchange 234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0