ACCOLADE EUROPE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ACCOLADE EUROPE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02830414 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ACCOLADE EUROPE LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ACCOLADE EUROPE LIMITED?
Dirección de la sede social | Thomas Hardy House 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Surrey |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ACCOLADE EUROPE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
MATTHEW CLARK WHOLESALE BOND LIMITED | 01 may 1997 | 01 may 1997 |
FREETRADERS (GRANTS OF ST JAMES'S) LIMITED | 20 oct 1993 | 20 oct 1993 |
OVAL (888) LIMITED | 25 jun 1993 | 25 jun 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ACCOLADE EUROPE LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2017 |
Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2018 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ACCOLADE EUROPE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Registro de la carga 028304140003, creada el 14 oct 2016 | 37 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga 028304140002, creada el 14 oct 2016 | 68 páginas | MR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Anthony Graham Wood el 02 oct 2015 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Jeremy Alexander Stevenson el 02 oct 2015 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Michael Schaafsma el 02 oct 2015 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robert John Ratcliffe el 02 oct 2015 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Steven Lee Gorst el 02 oct 2015 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Jeremy Alexander Stevenson el 02 oct 2015 | 3 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mrs Nicola Jane Spencer el 02 oct 2015 | 3 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de , Accolade House the Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR a Thomas Hardy House 2 Heath Road Weybridge Surrey KT13 8TB el 25 ago 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Restauración por orden judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Steven Lee Gorst el 01 jun 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Anthony Graham Wood como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ACCOLADE EUROPE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPENCER, Nicola Jane | Secretario | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | 180939000001 | |||||||
STEVENSON, Jeremy Alexander | Secretario | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | 161850330001 | |||||||
GORST, Steven Lee | Director | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Canada | Canadian | Company Director | 180938750002 | ||||
RATCLIFFE, Robert John | Director | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Management Consultant | 185752460001 | ||||
SCHAAFSMA, Paul Michael | Director | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 105189170004 | ||||
STEVENSON, Jeremy Alexander | Director | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Solicitor | 161846280001 | ||||
WOOD, Anthony Graham | Director | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Financial Controller | 185752470001 | ||||
CLOTHIER, Esther | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 162012580001 | |||||||
COLQUHOUN, Anne Therese | Secretario | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | 28396500005 | ||||||
GREGORY, David Noel | Secretario | 15 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | British | Company Director | 14735490001 | |||||
HUGHES, David John | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 157467610002 | |||||||
MALHOTRA, Deepak Kumar | Secretario | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | British | Solicitor | 69554640002 | |||||
OVALSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||
AIKENS, Peter | Director | Princes Lodge BA4 5HN Shepton Mallet Somerset | British | Company Director | 2228040002 | |||||
BONES, David Christopher | Director | 6 Trowle Common BA14 9BJ Trowbridge Wiltshire | England | British | Director | 60302270001 | ||||
BROCKETT, Gavin Stuart | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | South African | Accountant | 167554030002 | ||||
CHRISTENSEN, Troy | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | American | Company Director | 130789730003 | ||||
COLQUHOUN, Anne Therese | Director | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | Company Secretary | 28396500005 | ||||
CRANE, Charles Michael | Director | 41 Queens Gardens W2 3AA London | British | Director | 14735480001 | |||||
CREIGHTON, Thomas Hugh | Director | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | Accountant | 157727790001 | ||||
DICK, Thomas Gordon | Director | Yew House Giffards Meadow GU9 8DA Farnham Surrey | British | Company Director | 46246620001 | |||||
ETHERIDGE, Hugh Charles | Director | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | Company Director | 1491130002 | ||||
FISHER, David Michael | Director | Ashley Wood Kingsdown SN14 9BH Corsham Wiltshire | British | Company Director | 76571110001 | |||||
GLENNIE, Helen Margaret | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 137615160001 | ||||
GREGORY, David Noel | Director | 15 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | Company Director | 14735490001 | ||||
HODGES, Nigel Ian | Director | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | Business Development Director | 75692570001 | |||||
HOYLE, Russell Blackburn | Director | 77 Richmond Park Road East Sheen SW14 8JY London | British | Company Director | 52822380001 | |||||
HUGHES, David John | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Accountant | 157415150002 | ||||
HUNTLEY, Peter William | Director | 28 Allan Glen Gardens Bishopbriggs G64 3BG Glasgow | Scotland | British | Company Director | 46387640002 | ||||
KLEIN, David | Director | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | Company Director | 119928070001 | |||||
LOUSADA, James David | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 152222000001 | ||||
MALHOTRA, Deepak Kumar | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 69554640002 | ||||
O'HALLERAN, James William | Director | Barndale Abbotts Bromley Road DE13 8RA Hoar Cross Staffordshire | British | Company Director | 103876820001 | |||||
PETERS, Richard David | Director | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | Director | 60630980002 | ||||
RUGGERI, Andrea Aldo | Director | Hermitage 4 Mendip Leigh West Harptree Road, East Harptree BS40 6BQ Bristol Avon | United Kingdom | British | Director | 36468270002 |
¿Tiene ACCOLADE EUROPE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 14 oct 2016 Entregado el 31 oct 2016 | Pendiente | ||
Breve descripción Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the original transaction security. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 14 oct 2016 Entregado el 21 oct 2016 | Pendiente | ||
Breve descripción Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the deed. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 18 oct 2011 Entregado el 25 oct 2011 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & equipment. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0