ACCOLADE EUROPE LIMITED

ACCOLADE EUROPE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaACCOLADE EUROPE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02830414
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Thomas Hardy House
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MATTHEW CLARK WHOLESALE BOND LIMITED01 may 199701 may 1997
    FREETRADERS (GRANTS OF ST JAMES'S) LIMITED20 oct 199320 oct 1993
    OVAL (888) LIMITED25 jun 199325 jun 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2017
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2018
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016

    5 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015

    12 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014

    4 páginasAA

    Registro de la carga 028304140003, creada el 14 oct 2016

    37 páginasMR01

    Registro de la carga 028304140002, creada el 14 oct 2016

    68 páginasMR01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 sept 2016

    Estado de capital el 13 sept 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 sept 2016

    Estado de capital el 12 sept 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Anthony Graham Wood el 02 oct 2015

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Jeremy Alexander Stevenson el 02 oct 2015

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Paul Michael Schaafsma el 02 oct 2015

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Robert John Ratcliffe el 02 oct 2015

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Steven Lee Gorst el 02 oct 2015

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Jeremy Alexander Stevenson el 02 oct 2015

    3 páginasCH03

    Cambio de datos del secretario Mrs Nicola Jane Spencer el 02 oct 2015

    3 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de , Accolade House the Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR a Thomas Hardy House 2 Heath Road Weybridge Surrey KT13 8TB el 25 ago 2016

    2 páginasAD01

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr Steven Lee Gorst el 01 jun 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 jun 2014

    Estado de capital el 09 jun 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nombramiento de Mr Anthony Graham Wood como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de ACCOLADE EUROPE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SPENCER, Nicola Jane
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    180939000001
    STEVENSON, Jeremy Alexander
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    161850330001
    GORST, Steven Lee
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    CanadaCanadianCompany Director180938750002
    RATCLIFFE, Robert John
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishManagement Consultant185752460001
    SCHAAFSMA, Paul Michael
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director105189170004
    STEVENSON, Jeremy Alexander
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianSolicitor161846280001
    WOOD, Anthony Graham
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianFinancial Controller185752470001
    CLOTHIER, Esther
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    162012580001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Secretario
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    British28396500005
    GREGORY, David Noel
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Secretario
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director14735490001
    HUGHES, David John
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    157467610002
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Secretario
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    BritishSolicitor69554640002
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secretario designado corporativo
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    AIKENS, Peter
    Princes Lodge
    BA4 5HN Shepton Mallet
    Somerset
    Director
    Princes Lodge
    BA4 5HN Shepton Mallet
    Somerset
    BritishCompany Director2228040002
    BONES, David Christopher
    6 Trowle Common
    BA14 9BJ Trowbridge
    Wiltshire
    Director
    6 Trowle Common
    BA14 9BJ Trowbridge
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector60302270001
    BROCKETT, Gavin Stuart
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaSouth AfricanAccountant167554030002
    CHRISTENSEN, Troy
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAmericanCompany Director130789730003
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Director
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    United KingdomBritishCompany Secretary28396500005
    CRANE, Charles Michael
    41 Queens Gardens
    W2 3AA London
    Director
    41 Queens Gardens
    W2 3AA London
    BritishDirector14735480001
    CREIGHTON, Thomas Hugh
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    Director
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    EnglandBritishAccountant157727790001
    DICK, Thomas Gordon
    Yew House Giffards Meadow
    GU9 8DA Farnham
    Surrey
    Director
    Yew House Giffards Meadow
    GU9 8DA Farnham
    Surrey
    BritishCompany Director46246620001
    ETHERIDGE, Hugh Charles
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Director
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    United KingdomBritishCompany Director1491130002
    FISHER, David Michael
    Ashley Wood
    Kingsdown
    SN14 9BH Corsham
    Wiltshire
    Director
    Ashley Wood
    Kingsdown
    SN14 9BH Corsham
    Wiltshire
    BritishCompany Director76571110001
    GLENNIE, Helen Margaret
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Director
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director137615160001
    GREGORY, David Noel
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Director
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director14735490001
    HODGES, Nigel Ian
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    Director
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    BritishBusiness Development Director75692570001
    HOYLE, Russell Blackburn
    77 Richmond Park Road
    East Sheen
    SW14 8JY London
    Director
    77 Richmond Park Road
    East Sheen
    SW14 8JY London
    BritishCompany Director52822380001
    HUGHES, David John
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianAccountant157415150002
    HUNTLEY, Peter William
    28 Allan Glen Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3BG Glasgow
    Director
    28 Allan Glen Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3BG Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director46387640002
    KLEIN, David
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    Director
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    AmericanCompany Director119928070001
    LOUSADA, James David
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director152222000001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Director
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor69554640002
    O'HALLERAN, James William
    Barndale
    Abbotts Bromley Road
    DE13 8RA Hoar Cross
    Staffordshire
    Director
    Barndale
    Abbotts Bromley Road
    DE13 8RA Hoar Cross
    Staffordshire
    BritishCompany Director103876820001
    PETERS, Richard David
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    Director
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector60630980002
    RUGGERI, Andrea Aldo
    Hermitage 4 Mendip Leigh
    West Harptree Road, East Harptree
    BS40 6BQ Bristol
    Avon
    Director
    Hermitage 4 Mendip Leigh
    West Harptree Road, East Harptree
    BS40 6BQ Bristol
    Avon
    United KingdomBritishDirector36468270002

    ¿Tiene ACCOLADE EUROPE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 14 oct 2016
    Entregado el 31 oct 2016
    Pendiente
    Breve descripción
    Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the original transaction security.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (as New UK Security Trustee)
    Transacciones
    • 31 oct 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 14 oct 2016
    Entregado el 21 oct 2016
    Pendiente
    Breve descripción
    Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the deed.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (as UK Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 oct 2016Registro de una carga (MR01)
    Debenture
    Creado el 18 oct 2011
    Entregado el 25 oct 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & equipment. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Commercial Distribution Finance Europe Limited (As UK Security Trustee)
    Transacciones
    • 25 oct 2011Registro de un cargo (MG01)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0