G4S ADI GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaG4S ADI GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02831083
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de G4S ADI GROUP LIMITED?

    • Actividades de seguridad privada (80100) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra G4S ADI GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Sutton Park House
    15 Carshalton Road
    SM1 4LD Sutton
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de G4S ADI GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SECURICOR ADI GROUP LIMITED16 feb 200116 feb 2001
    THE ADI GROUP LIMITED03 ago 199303 ago 1993
    MAWLAW 209 LIMITED28 jun 199328 jun 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de G4S ADI GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para G4S ADI GROUP LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para G4S ADI GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Giovanni Nicholas Grosso como director el 19 may 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 10 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 may 2015

    Estado de capital el 12 may 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    14 páginasAA

    Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa

    1 páginasDS02

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 31 dic 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 10 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 may 2014

    Estado de capital el 14 may 2014

    • Capital: GBP 10,296,868
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    15 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    14 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed securicor adi group LIMITED\certificate issued on 27/06/13
    2 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name27 jun 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 31 may 2013

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Déclaration annuelle établie au 10 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Andrew Farquhar como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Farquhar como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 10 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Mrs Vaishali Jagdish Patel el 01 abr 2012

    2 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de G4S ADI GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PATEL, Vaishali Jagdish
    Victoria Street
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    Secretario
    Victoria Street
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    BritishSolicitor132281580001
    HEWITSON, Douglas Charles
    Sutton Park House
    15 Carshalton Road
    SM1 4LD Sutton
    Surrey
    Director
    Sutton Park House
    15 Carshalton Road
    SM1 4LD Sutton
    Surrey
    EnglandBritishDirector106978540001
    COTTON, Nigel Duncan John
    3 Windlesham Gardens
    BN43 5AD Shoreham By Sea
    West Sussex
    Secretario
    3 Windlesham Gardens
    BN43 5AD Shoreham By Sea
    West Sussex
    British42199060001
    GATESON, Leonard Keith
    Casteye Barn
    Haywards Heath Road
    RH17 6NZ Balcome
    West Sussex
    Secretario
    Casteye Barn
    Haywards Heath Road
    RH17 6NZ Balcome
    West Sussex
    British149585720001
    LYELL, Stephen Edward
    122 Lambton Road
    SW20 0TJ London
    Secretario
    122 Lambton Road
    SW20 0TJ London
    Other118713120001
    MORRIS, Patrick Charles
    Thames Cottage Church Square
    TW17 9JY Shepperton
    Middlesex
    Secretario
    Thames Cottage Church Square
    TW17 9JY Shepperton
    Middlesex
    BritishAccountant35885390001
    MUNSON, Anne Patricia
    21 Nymans Close
    RH12 5JR Horsham
    West Sussex
    Secretario
    21 Nymans Close
    RH12 5JR Horsham
    West Sussex
    British64738610001
    POMROY, Graham
    Morning Quest
    22 Burgh Heath Road
    KT17 4LS Epsom
    Surrey
    Secretario
    Morning Quest
    22 Burgh Heath Road
    KT17 4LS Epsom
    Surrey
    BritishAccountant76047020001
    RICHARDS, Nathan
    26 Kingswood Drive
    SM2 5NB Sutton
    Surrey
    Secretario
    26 Kingswood Drive
    SM2 5NB Sutton
    Surrey
    British93549510001
    VENUS, David Anthony
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    British38563740001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secretario corporativo
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    AGGAR, Martin Robert
    210 Guildford Road
    GU18 5RL Lightwater
    Surrey
    Director
    210 Guildford Road
    GU18 5RL Lightwater
    Surrey
    BritishDirector124053450001
    ARGENBRIGHT, Francis Andrew
    40 Valley Road
    Atlanta
    Georgia 30305
    Usa
    Director
    40 Valley Road
    Atlanta
    Georgia 30305
    Usa
    AmericanDirector & Chief Executive35885570002
    BEATON, David James
    25 Saint Marys Road
    GU33 7AH Liss
    Hampshire
    Director
    25 Saint Marys Road
    GU33 7AH Liss
    Hampshire
    BritishCompany Director100525410001
    BRADBURY, Vincent Alan Michael
    Morvich
    Argyll Road, Kilcreggan
    G84 0JR Helensburgh
    Dunbartonshire
    Director
    Morvich
    Argyll Road, Kilcreggan
    G84 0JR Helensburgh
    Dunbartonshire
    ScotlandUnited KingdomDirector175534200001
    BUCKLES, Nicholas Peter
    Swissland Hill
    Dormans Park
    RH19 2NH East Grinstead
    Rede Place
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Swissland Hill
    Dormans Park
    RH19 2NH East Grinstead
    Rede Place
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector132107860001
    CHALLIS, Kamini
    34 Windermere
    Liden
    SN3 6JZ Swindon
    Wiltshire
    Director
    34 Windermere
    Liden
    SN3 6JZ Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director73383780001
    DIGHTON, Trevor Leslie
    The Black Barn
    Green Lane Marden
    TN12 9RA Tonbridge
    Kent
    Director
    The Black Barn
    Green Lane Marden
    TN12 9RA Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director148937480001
    DOMANICO, Ronald
    2 Buckingham Court
    Morristown
    New Jersey 07960
    Usa
    Director
    2 Buckingham Court
    Morristown
    New Jersey 07960
    Usa
    AmericanDirector70864410001
    EWELL, Melvyn
    89 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    89 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector61515760001
    FADIL, Susan Carol
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    Director designado
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    British900006600001
    FARQUHAR, Andrew James
    Sutton Park House
    15 Carshalton Road
    SM1 4LD Sutton
    Surrey
    Director
    Sutton Park House
    15 Carshalton Road
    SM1 4LD Sutton
    Surrey
    EnglandBritishAccountant148383420001
    FARQUHAR, Andrew James
    Sutton Park House
    15 Carshalton Road
    SM1 4LD Sutton
    Surrey
    Director
    Sutton Park House
    15 Carshalton Road
    SM1 4LD Sutton
    Surrey
    EnglandBritishAccountant148383420001
    FOX, Donald Frederic
    2994 Clary Hill Court
    Roswell
    30075 Georgia
    Usa
    Director
    2994 Clary Hill Court
    Roswell
    30075 Georgia
    Usa
    AmericanChief Financial Officer36280240001
    FRANKLIN, Kevin Nigel
    35 Thyme Close
    Chineham
    RG24 8XG Basingstoke
    Hampshire
    Director
    35 Thyme Close
    Chineham
    RG24 8XG Basingstoke
    Hampshire
    BritishFinance Director39318340003
    GAMSEY, David Lee
    115 Marsh Glen Point
    GA 30328 Atlanta
    Georgia
    Usa
    Director
    115 Marsh Glen Point
    GA 30328 Atlanta
    Georgia
    Usa
    AmericanChief Financial Officer45558690001
    GRIFFITHS, Nigel Edward
    23 The Highway
    SM2 5QT Sutton
    Surrey
    Director
    23 The Highway
    SM2 5QT Sutton
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director26909580002
    GROSSO, Giovanni Nicholas
    Sutton Park House
    15 Carshalton Road
    SM1 4LD Sutton
    Surrey
    Director
    Sutton Park House
    15 Carshalton Road
    SM1 4LD Sutton
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director85104050001
    GUMMERS, Eric Michael
    9 Vincent Square Mansions
    Walcott Street
    SW1P 2NT London
    Director designado
    9 Vincent Square Mansions
    Walcott Street
    SW1P 2NT London
    British900006590001
    HEWITSON, Douglas Charles
    1 Harwood Park
    RH1 5EJ Salfords
    Surrey
    Director
    1 Harwood Park
    RH1 5EJ Salfords
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director106978540001
    MELLETT, Edwin Robert
    725 West Conway Drive
    30327 Atlanta
    Georgia
    Usa
    Director
    725 West Conway Drive
    30327 Atlanta
    Georgia
    Usa
    AmericanCompany Chief Executive42198940002
    MORRIS, Patrick Charles
    Thames Cottage Church Square
    TW17 9JY Shepperton
    Middlesex
    Director
    Thames Cottage Church Square
    TW17 9JY Shepperton
    Middlesex
    BritishAccountant35885390001
    PATTERSON, Ernest
    1 Hillside Road
    Penn
    HP10 8JJ High Wycombe
    Director
    1 Hillside Road
    Penn
    HP10 8JJ High Wycombe
    BritishCeo83721290001
    SAVOY, Robert Charles
    110 Trailridge Lane
    Dunwoody Georgia 30338
    FOREIGN Usa
    Director
    110 Trailridge Lane
    Dunwoody Georgia 30338
    FOREIGN Usa
    AmericanPresident35885480001
    THORNLEY, Ian
    Leeside Lodge 1 Leeside
    Horsham Road Rusper
    RH12 4PR Horsham
    West Sussex
    Director
    Leeside Lodge 1 Leeside
    Horsham Road Rusper
    RH12 4PR Horsham
    West Sussex
    BritishCorporate Development43123020001

    ¿Tiene G4S ADI GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Share mortgage (over shares in adi U.K. limited and aviation defence international germany limited (the "deed"))
    Creado el 13 oct 1999
    Entregado el 28 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee on its own behalf and as administrative agent and security trustee for the lenders (as therein defined) under or pursuant to the second credit agreement or any other loan document (as therein defined) to which the company or any of them is a party and all other monies agreed to be paid pursuant to the deed
    Breve descripción
    All right title interest and benefit in and to the shares (as defined) and the rights (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • First Union National Bank
    Transacciones
    • 28 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 13 oct 1999
    Entregado el 28 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as security trustee on its own behalf and as administrative agent and security trustee for the lenders (as therein defined) under or pursuant to the second credit agreement or any other loan document (as therein defined) to which the company is a party and all other monies agreed to be paid pursuant to the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • First Union National Bank
    Transacciones
    • 28 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee
    Creado el 02 may 1997
    Entregado el 21 may 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors (as defined) to the chargee for the benefit of itself and the other lenders (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge over including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • First Union National Bank of Georgia
    Transacciones
    • 21 may 1997Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creado el 02 may 1997
    Entregado el 21 may 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors (as defined) to the chargee for the benefit of itself and the other lenders (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    218707 ordinary shares of £1 each in adi UK limited registered in the name of the company; 29851 ordinary shares of £1 each in aviation defence international germany limited registered in the name of the company; all the shares in the capital of adi UK limited and aviation defence international germany limited now or hereafter beneficially owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • First Union National Bank of Georgia
    Transacciones
    • 21 may 1997Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creado el 22 dic 1995
    Entregado el 05 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or aviation defence international germany limited and adi UK limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    218707 ordinary shares of £1 each in adi UK limited registered in the name of the company. 29851 ordinary shares of £1 each in aviation defense international germany limited registered in the name of the company. All the shares in the capital of adi UK limited and aviation defense international germany limited now or hereafter beneficially owned by the company. All dividends distributions bonus shares rights etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • First Union Commercial Corporation
    Transacciones
    • 05 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 dic 1995
    Entregado el 05 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • First Union Commercial Corporation
    Transacciones
    • 05 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 04 oct 1993
    Entregado el 14 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 11 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0