BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED

BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02831648
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CLEARTEST LIMITED30 jun 199330 jun 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    4 páginasMR04

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 nov 2017

    8 páginasLIQ03

    Notification de Bl Retail Warehousing Holding Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2017

    1 páginasPSC02

    Cese del nombramiento de Christopher Michael John Forshaw como director el 05 abr 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Jonathan Charles Mcnuff como director el 03 abr 2017

    2 páginasAP01

    Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 7

    5 páginasMR05

    Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 4

    5 páginasMR05

    Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 9

    5 páginasMR05

    Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 6

    5 páginasMR05

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 22 nov 2016

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 10 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Charles Mcnuff como director el 10 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy Andrew Roberts como director el 10 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Stuart Macey como director el 10 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 10 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Lucinda Margaret Bell como director el 10 nov 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro8992198
    187856670001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    BRAINE, Anthony
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Secretario
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British32809000002
    PENRICE, Victoria Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    190034210001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish32809050044
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British166550001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    BRAINE, Anthony
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MACEY, Paul Stuart
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205652070001
    MADDISON, John Roman Patrick
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish159016320001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Director
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    PENRICE, Victoria Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish189931090001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Director
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritish41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Director
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Director
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritish79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritish63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish148183670001
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish148183670001
    VANDEVIVERE, Jean-Marc
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomFrench170947050001
    WEBB, Nigel Mark
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Director
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritish13547380001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2017
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro6002154
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroUnited Kingdom Companies Registry
    Número de registro6002154
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 17 jun 2009
    Entregado el 22 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/A title of the homebase store twickenham road feltham with full title guarantee and free from any other security interest and otherwise by way of fixed charge, all legal interests in the property see image for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited
    Transacciones
    • 22 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 17 jun 2009
    Entregado el 22 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/A title of the homebase store north side of sandy's hill lane frome somerset with full title guarantee and free from any other security interest and otherwise by way of fixed charge, all legal interests in the property see image for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited
    Transacciones
    • 22 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 17 jun 2009
    Entregado el 22 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/A title of the homebase store rushworth road reigate surrey with full title guarantee and free from any other security interest and otherwise by way of fixed charge, all legal interests in the property see image for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited
    Transacciones
    • 22 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A twenty-first supplemental composite trust deed
    Creado el 24 abr 2009
    Entregado el 29 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the principal of and interest on all the debentures
    Breve descripción
    The f/h land show edged with red on the plan of the title being land on the north side of broadway royton t/n GM821517. The f/h land shown edged with red being land lying to the north of broadway royton t/n GM550159. The f/h land shown edged with red being land on the north side of broadway royton t/n GM686645. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transacciones
    • 29 abr 2009Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Fourth supplemental composite trust deed
    Creado el 14 mar 2007
    Entregado el 19 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the british land company PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land and buildings on the north side of lower bristol road and the west side of brook road twerton t/n ST2858 all buildings and erections fixtures and fittings fixed plant and machinery benefit of all leases.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited as Trustee
    Transacciones
    • 19 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2017Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 07 mar 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Third composite supplemental trust deed
    Creado el 01 ene 2007
    Entregado el 10 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the principal of and interest on all the debentures
    Breve descripción
    Land and buildings on the north east side of reigate road ewell t/no sy 670162 and land on the north east side of durnsford road wimbledon t/no sgl 1790947 for further details of property charged please refer to form 395 all together with fixtures erections and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transacciones
    • 10 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 30 nov 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 09 oct 2015Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    • 12 ene 2017Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 07 mar 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A composite supplemental trust deed
    Creado el 29 ago 2006
    Adquirido el 01 ene 2007
    Entregado el 24 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Springfield retail park edgar road elgin cuckoo bridge retail park glasgow road dumfries t/nos DMF6641 and DMF6871 and st james retail park dumbarton t/no DMB31472.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transacciones
    • 24 ene 2007Registro de una adquisición (400)
    • 26 mar 2014Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    • 22 jul 2014Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 25 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A composite supplemental trust deed
    Creado el 29 ago 2006
    Adquirido el 01 ene 2007
    Entregado el 24 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land and buildings on the north east side of reigate road (ewell homebase) with t/nos SY670162 and SY670947 land on the north east side of durnsford road wimbledon (wimbledon homebase) t/no SGL179482 land lying to the north west ickneild way luton (luton homebase) for details of further properties charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transacciones
    • 24 ene 2007Registro de una adquisición (400)
    • 10 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 10 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 20 ene 2017Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 07 mar 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A composite supplemental trust deed
    Creado el 29 ago 2006
    Entregado el 13 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the british land company PLC as issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The eastgate centre, co-operative house, town square, 2 to 14 (even) east walk, 3 to 9 (odd) south gunnels, 46 to 54 (even) and 81, 83 and 85 southernhay, 10 to 16 gateway, the eastgate business centre, southernhay, kelting house and commercial union house basildon t/no EX363917. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The Trustee)
    Transacciones
    • 13 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 04 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An eleventh supplemental trust deed made between the british land company PLC ("british land"), certain of its subsidiaries (including the company) and royal exchange trust company limited (the "trustee") to the trust supplemental deed dated 29 april 1993 (the "principal trust deed") and ten trust deeds supplemental thereto between (inter alios) british land and trustee
    Creado el 30 abr 2001
    Entregado el 14 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The total amount payable under the trust deeds referred to above, namely the principal of, and interest on the £200,000,000 9 3/8 per cent. First mortgage debenture stock 2028 of british land (the "stock") and constituted and secured by a trust deed supplemental to the principal trust deed and all other monies intended to be secured by or payable under or pursuant to the trust deeds or any future trust deed supplemental to the principal trust deed.
    Breve descripción
    By way of a first fixed charge over all companys right title and interest in the property legal and general house st.monica's road kingswood london borough surrey reigate and banstead title number SY641364 together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery for time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrances.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited as Trustee for the Holders of Thestock
    Transacciones
    • 14 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2017Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 07 mar 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    An eighth supplemental trust deed dated the 22ND february 1999
    Creado el 22 feb 1999
    Entregado el 09 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the british land company PLC (the "issuer"), all further bonds (as defined in the principal trust deed dated 6TH october, 1995 (the "principal trust deed")) whether or not of the same series, and all other monies payable by the issuer to the trustee (as defined in the principal trust deed) under the terms of the principal trust deed
    Breve descripción
    The property known as eastgate shopping centre basildon essex title number EX363917 all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery all existing leases underleases, tenancies, agreements for lease, rights, covenants and conditons.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transacciones
    • 09 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Second supplemental trust deed
    Creado el 14 mar 1996
    Entregado el 01 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the british land company PLC (the "issuer"), all further bonds (as defined in the principal trust deed dated 6TH october, 1995 (the "principal trust deed")) whether or not of the same series, and all other monies payable by the issuer to the chargee (as defined in the principal trust deed) under the terms of the principal trust deed
    Breve descripción
    Land and buildings on the west side of wheatlea road goose green wigan greater manchester t/n-GM604769. Woodlands court albert drive burgess hill west sussex t/n-WSX186613. Land on the north east side of bull street and the south west side of priory ringway birmingham (k/a temple court) birmingham west midalnds t/n-WM451682 and WM576974.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited (As Trustee)
    Transacciones
    • 01 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 10 oct 1996Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 31 oct 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 25 feb 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 22 mar 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 17 sept 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BRITISH LAND RETAIL WAREHOUSES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 nov 2016Inicio de la liquidación
    02 sept 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0