TILNEY HOLDINGS LIMITED

TILNEY HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTILNEY HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02834931
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    ¿Dónde se encuentra TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REPORTPROFIT LIMITED09 jul 199309 jul 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    4 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 sept 2012

    3 páginas4.68

    Cese del nombramiento de David Robert Wetherell como director el 08 ago 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Joerg Friedrich Modersohn como director el 03 oct 2011

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Royal Liver Building Pier Head Liverpool L3 1NY el 14 oct 2011

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 sept 2011

    LRESSP

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 08 jun 2011

    • Capital: GBP 38,717,197.21
    4 páginasSH01

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Estado de capital el 23 jun 2011

    • Capital: GBP 100
    4 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Subdivision 08/06/2011
    RES13
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Subdivisión de acciones el 08 jun 2011

    5 páginasSH02

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    10 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    16 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Ian Lewis Bennett como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Zoe Whatmore como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Zoe Victoria Whatmore el 16 mar 2010

    3 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de TILNEY HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAGSHAW, Joanne Louise
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Secretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British81157100004
    BARTLETT, Andrew William
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Secretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British73852930003
    BENNETT, Ian Lewis
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United KingdomBritish152455200001
    NORBURY, John Douglas
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish8083120003
    WETHERELL, David Robert
    Copley Manor Road
    Thornton Hough
    L63 1JB Wirral
    Merseyside
    Secretario
    Copley Manor Road
    Thornton Hough
    L63 1JB Wirral
    Merseyside
    British41582480001
    WHITFIELD, Robert Jeffery
    Wayside Firs Lane
    Appleton
    WA4 5LD Warrington
    Cheshire
    Secretario
    Wayside Firs Lane
    Appleton
    WA4 5LD Warrington
    Cheshire
    British26088590001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENNETT, Phillip Roger
    125 Colt Lane
    Gladstone
    New Jersey 07934 Usa
    Director
    125 Colt Lane
    Gladstone
    New Jersey 07934 Usa
    British45097010001
    BIRD, Terrence Stanley
    3 Portland Drive
    Clay Hill
    EN2 9AT Enfield
    Director
    3 Portland Drive
    Clay Hill
    EN2 9AT Enfield
    British95741510001
    CAMPBELL, David Alistair
    2 Riverdale Road
    TW1 2BS Twickenham
    Middlesex
    Director
    2 Riverdale Road
    TW1 2BS Twickenham
    Middlesex
    British60653150003
    GRANT, Tone North
    135 South La Salle Street
    Suite 2400
    Chicago
    Illinois 60603
    Usa
    Director
    135 South La Salle Street
    Suite 2400
    Chicago
    Illinois 60603
    Usa
    American26539870001
    GREEN, Peter Robert
    Pineridge
    Lifeboat Road
    L37 2EB Formby
    Merseyside
    Director
    Pineridge
    Lifeboat Road
    L37 2EB Formby
    Merseyside
    British1223440003
    LESSELS, Norman
    11 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    Director
    11 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    British681350002
    MITCHELL, John David
    Ashfield Cottages
    Dark Lane, Higher Whitley
    WA4 4QG Warrington
    Cheshire
    Director
    Ashfield Cottages
    Dark Lane, Higher Whitley
    WA4 4QG Warrington
    Cheshire
    British1172830001
    MODERSOHN, Joerg Friedrich
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Other136313410001
    OKELL, Philip Charles
    Green Butts Farm
    Long Lane
    CW6 9TB Spurstow
    Cheshire
    Director
    Green Butts Farm
    Long Lane
    CW6 9TB Spurstow
    Cheshire
    United KingdomBritish9542910002
    OKELL, Philip Charles
    Shenella Bank Cottage
    Tilstone Fearnall
    CW6 9HP Tarporley
    Cheshire
    Director
    Shenella Bank Cottage
    Tilstone Fearnall
    CW6 9HP Tarporley
    Cheshire
    British9542910001
    WEBSTER, David Stephen
    25 Barton Road
    CH47 1HJ Hoylake
    Merseyside
    Director
    25 Barton Road
    CH47 1HJ Hoylake
    Merseyside
    United KingdomBritish83843470001
    WETHERELL, David Robert
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    British41582480002
    WHATMORE, Zoe Victoria
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish163197030001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene TILNEY HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security accession deed
    Creado el 16 may 2005
    Entregado el 01 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transacciones
    • 01 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Shares pledge
    Creado el 16 may 2005
    Entregado el 01 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the pledgor or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Its entire right, title and interest in and to the shares and in and to the securities all dividends, monies and assets in respect of the shares or the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 01 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 06 feb 2004
    Entregado el 19 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the administrative agent and to the vendors or each of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The chargor with full title guarantee and as continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities has charged the securities and the derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Robert Court as Administrative Agent for and on Behalf of the Vendors
    Transacciones
    • 19 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 20 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of pledge
    Creado el 04 oct 1993
    Entregado el 22 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All stocks,shares,bonds debentures and other securities which have been assigned and/or transfered to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 04 oct 1993
    Entregado el 22 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letter d/d 24/09/93 see charge particulars form for details
    Breve descripción
    All right title and interest in and all benefits accruing from the loan agreement d/d 4/10/93. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 oct 1993
    Entregado el 22 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TILNEY HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 abr 2013Fecha de disolución
    30 sept 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0