APTA HEALTHCARE LIMITED

APTA HEALTHCARE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAPTA HEALTHCARE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02837814
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de APTA HEALTHCARE LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra APTA HEALTHCARE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de APTA HEALTHCARE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MIDLAND ASSETS PLC21 abr 199421 abr 1994
    NOTTINGHAM HOLDINGS PLC15 oct 199315 oct 1993
    LIMEGLADE PLC20 jul 199320 jul 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de APTA HEALTHCARE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para APTA HEALTHCARE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr David Charles Lovett como director el 31 ago 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 31 ago 2012

    1 páginasTM01

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    6 páginas1.4

    Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor

    4 páginas1.1

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 ene 2012

    Estado de capital el 18 ene 2012

    • Capital: GBP 3,827,777.8
    SH01

    Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    19 páginasAA

    Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Richard Midmer como director

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2009

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr David Andrew Smith el 07 ene 2010

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Smith como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de APTA HEALTHCARE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Director
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    BAKER, Graham
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    Secretario
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    British40240710001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Secretario
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Secretario
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Secretario
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304630001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Secretario
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SMITH, Peter Anthony
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    Secretario
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    British71842080001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    STARK, Michael Joseph
    63 Newberries Avenue
    WD7 7EL Radlett
    Hertfordshire
    Secretario
    63 Newberries Avenue
    WD7 7EL Radlett
    Hertfordshire
    British25984240001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Director
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BAKER, Graham
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    Director
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    British40240710001
    BALLANTYNE, Thomas Niven
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    Director
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    EnglandBritish68970050002
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    Director
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    American51593550001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    CALONDER, Felix Guido
    Loostrasse 2
    8703 Erlenbach
    FOREIGN Zurich
    Switzerland
    Director
    Loostrasse 2
    8703 Erlenbach
    FOREIGN Zurich
    Switzerland
    Swiss3480990001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Director designado
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Director
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Director
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    British76212360001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Director
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Director
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Director
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    GWATKIN, Peter Frederick Stapleton
    Shustoke Hall Moathouse Lane
    Shustoke Coleshill
    B46 2RJ Birmingham
    Director
    Shustoke Hall Moathouse Lane
    Shustoke Coleshill
    B46 2RJ Birmingham
    British42082340004
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Director
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish106162380001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Director
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001

    ¿Tiene APTA HEALTHCARE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 29 feb 2008
    Entregado el 14 mar 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 14 mar 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 06 jun 2007
    Entregado el 19 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 19 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 jul 2006
    Entregado el 20 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 20 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession and charge
    Creado el 02 dic 2005
    Entregado el 15 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 15 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 dic 1995
    Entregado el 12 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Wales
    Transacciones
    • 12 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 08 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 ago 1995
    Entregado el 17 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 08 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene APTA HEALTHCARE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 jun 2012Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    20 ago 2012Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0