APTA HEALTHCARE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | APTA HEALTHCARE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02837814 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de APTA HEALTHCARE LIMITED?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra APTA HEALTHCARE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de APTA HEALTHCARE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MIDLAND ASSETS PLC | 21 abr 1994 | 21 abr 1994 |
| NOTTINGHAM HOLDINGS PLC | 15 oct 1993 | 15 oct 1993 |
| LIMEGLADE PLC | 20 jul 1993 | 20 jul 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de APTA HEALTHCARE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para APTA HEALTHCARE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Charles Lovett como director el 31 ago 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 31 ago 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Notificación de finalización del acuerdo voluntario | 6 páginas | 1.4 | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor | 4 páginas | 1.1 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Midmer como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2009 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Andrew Smith el 07 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Smith como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de APTA HEALTHCARE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVETT, David Charles | Director | The Grange SW19 4PS London 17 England England | United Kingdom | British | 34419700002 | |||||
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| BAKER, Graham | Secretario | 26 Hazelhurst Road Kings Heath B14 7PJ Birmingham West Midlands | British | 40240710001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Secretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Secretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Secretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Secretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Secretario | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158304630001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Secretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Secretario | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Secretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SMITH, Peter Anthony | Secretario | Forge Cottage Forge Lane, Shorne DA12 3DP Gravesend Kent | British | 71842080001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Secretario | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| STARK, Michael Joseph | Secretario | 63 Newberries Avenue WD7 7EL Radlett Hertfordshire | British | 25984240001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Director | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BAKER, Graham | Director | 26 Hazelhurst Road Kings Heath B14 7PJ Birmingham West Midlands | British | 40240710001 | ||||||
| BALLANTYNE, Thomas Niven | Director | Greystones Milnthorpe Road, Holme LA6 1PX Carnforth Lancashire | England | British | 68970050002 | |||||
| BARLOW, George Edward | Director | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Director | Pipers Cottage Grove Heath Road Ripley GU23 6EU Woking Surrey | American | 51593550001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| CALONDER, Felix Guido | Director | Loostrasse 2 8703 Erlenbach FOREIGN Zurich Switzerland | Swiss | 3480990001 | ||||||
| CHARLTON, Peter John | Director designado | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||
| COLVIN, William | Director | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| DAVIS, Mary | Director | Oakdene 200 Culduthel Road IV2 4BH Inverness | British | 76212360001 | ||||||
| FARRALL, Elaine Ann | Director | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FLAHERTY, James Paul | Director | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Director | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| GWATKIN, Peter Frederick Stapleton | Director | Shustoke Hall Moathouse Lane Shustoke Coleshill B46 2RJ Birmingham | British | 42082340004 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Director | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| HODGE, Robert John | Director | Nant Fawr Graig Road Lisvane CF14 0UF Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 106162380001 | |||||
| JAP, Chee Miau | Director | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 |
¿Tiene APTA HEALTHCARE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 29 feb 2008 Entregado el 14 mar 2008 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 06 jun 2007 Entregado el 19 jun 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 07 jul 2006 Entregado el 20 jul 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession and charge | Creado el 02 dic 2005 Entregado el 15 dic 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 dic 1995 Entregado el 12 dic 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 14 ago 1995 Entregado el 17 ago 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene APTA HEALTHCARE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA) |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0