GATEFORTH PARK LIMITED

GATEFORTH PARK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGATEFORTH PARK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02840715
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GATEFORTH PARK LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra GATEFORTH PARK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Somerset
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GATEFORTH PARK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TOPCHECK LIMITED29 jul 199329 jul 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GATEFORTH PARK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GATEFORTH PARK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 dic 2017

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    2 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 dic 2016

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    13 páginasAA

    Cese del nombramiento de John Stanley como director el 19 sept 2016

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2016 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Déclaration annuelle établie au 29 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 sept 2016

    Estado de capital el 08 sept 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Paul Thomas Wilson el 01 feb 2016

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    13 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    13 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Philip David Wilson el 16 nov 2015

    4 páginasCH01

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    ¿Quiénes son los directivos de GATEFORTH PARK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILSON, Philip
    Haddon Road
    Clontarf
    25
    Dublin 3
    Ireland
    Secretario
    Haddon Road
    Clontarf
    25
    Dublin 3
    Ireland
    Irish107845750001
    WILSON, Paul Thomas
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    Director
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    IrelandIrish175102510004
    WILSON, Philip David
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    Director
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    IrelandIrish176073380001
    WILSON, Ronald Christopher
    Tyholland House
    IRISH Tyholland
    Monaghan
    Ireland
    Director
    Tyholland House
    IRISH Tyholland
    Monaghan
    Ireland
    IrelandIrish144024000001
    GARRY, Michael
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Secretario
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Irish126468430001
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Secretario designado corporativo
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    CLAY, John Andrew
    35 Woodlands View
    Barlby
    YO8 7XL Selby
    North Yorkshire
    Director
    35 Woodlands View
    Barlby
    YO8 7XL Selby
    North Yorkshire
    British75734550001
    FINNAMORE, Des
    Clonkeen
    IRISH Carbury
    County Kildaire
    South Ireland
    Director
    Clonkeen
    IRISH Carbury
    County Kildaire
    South Ireland
    British40604280001
    GARRY, Michael
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Director
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Irish126468430001
    MACCANNA, Cahal
    29 Castleknock Lodge
    Castleknock
    Dublin
    Dublin 15
    Ireland
    Director
    29 Castleknock Lodge
    Castleknock
    Dublin
    Dublin 15
    Ireland
    Irish66911960001
    MIDDLEBROOK, Simon
    Burton Hall Farm
    Mill Lane Brayton
    YO8 9LD Selby
    North Yorkshire
    Director
    Burton Hall Farm
    Mill Lane Brayton
    YO8 9LD Selby
    North Yorkshire
    EnglandBritish48882160001
    SPENCER, Charles Christopher Alwyn
    The Mews
    29 York Place
    HG1 5RH Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    The Mews
    29 York Place
    HG1 5RH Harrogate
    North Yorkshire
    British76665020001
    STANLEY, John
    Riverside
    Athlumwey
    Navan
    County Meath
    Republic Of Ireland
    Director
    Riverside
    Athlumwey
    Navan
    County Meath
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish9508050001
    WALKER, David Arthur
    Bank Villa
    Newland Drax
    YO8 8PS Selby
    North Yorkshire
    Director
    Bank Villa
    Newland Drax
    YO8 8PS Selby
    North Yorkshire
    British36079820002
    WALSH, Patrick Anthony
    Barnadown
    IRISH Gorey
    Co Wexford
    Ireland
    Director
    Barnadown
    IRISH Gorey
    Co Wexford
    Ireland
    IrelandIrish63377340001
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Director designado corporativo
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005280001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GATEFORTH PARK LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Decisiondrive Limited
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    C/O Monaghan Mushrooms Limited
    England
    06 abr 2016
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    C/O Monaghan Mushrooms Limited
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroRegistrar Of Companies For England And Wales
    Número de registro03742194
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene GATEFORTH PARK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 04 nov 2011
    Entregado el 17 nov 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 17 nov 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 08 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 05 oct 2010
    Entregado el 26 oct 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First fixed charge the mortgage property,by way of mortgage any deed of easements or rights of way used in connection with the security assets and to the licences and all rights of recovery and compensation,the leases .leasing agreements,agreements for lease or hire purchase agreements see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 26 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 08 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 05 oct 2010
    Entregado el 26 oct 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First fixed charge the mortgage property,by way of mortgage any deed of easements or rights of way used in connection with the security assets and to the licences and all rights of recovery and compensation,the leases .leasing agreements,agreements for lease or hire purchase agreements see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 26 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 08 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite debenture
    Creado el 02 jun 2004
    Entregado el 22 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 22 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite debenture
    Creado el 02 jun 2004
    Entregado el 22 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 22 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite debenture (as defined)
    Creado el 26 oct 2001
    Entregado el 13 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 13 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 30 mar 1998
    Entregado el 08 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 08 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 31 ago 1993
    Entregado el 06 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 06 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0