PENN HOUSE (SWANSEA) LIMITED

PENN HOUSE (SWANSEA) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPENN HOUSE (SWANSEA) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02841835
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PENN HOUSE (SWANSEA) LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra PENN HOUSE (SWANSEA) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PENN HOUSE (SWANSEA) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WOODSFORD PROPERTIES (SWANSEA) LIMITED03 ago 199303 ago 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PENN HOUSE (SWANSEA) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PENN HOUSE (SWANSEA) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 03 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 ago 2010

    Estado de capital el 18 ago 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Christopher George White el 01 may 2010

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Maurice Moses Benady el 01 may 2010

    3 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2009

    5 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    10 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175(5)(a) quoted 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175(5)(a) quoted 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175(5)(a) quoted 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175(5)(a) quoted 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    10 páginasAA

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2006

    6 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2005

    12 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    1 páginas244

    ¿Quiénes son los directivos de PENN HOUSE (SWANSEA) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secretario corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Director
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Director
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister At Law80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001
    DENHAM, Timothy Maurice
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    Secretario
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    British51492670001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Secretario
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    BritishAccountant74688330002
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Secretario
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    BritishCompany Director2942350001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secretario designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BONAVERO, Yves Jean Marc
    54 St James`S Gardens
    W11 4RA London
    Director
    54 St James`S Gardens
    W11 4RA London
    EnglandFrenchCompany Director29119190003
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Director
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director11296610002
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director116927100001
    DUMAS, Markham Cresswell
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    Director
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    United KingdomBritishSelf Employed/Company Director31098150001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishChief Accountant163838050001
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Director
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    United KingdomBritishCompany Director2942350001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor60687110001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ¿Tiene PENN HOUSE (SWANSEA) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 19 oct 1999
    Entregado el 23 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property known as land on the south side of carmarthen road, swansea t/no: WA352041. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creado el 18 oct 1999
    Entregado el 23 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 17 feb 1995
    Entregado el 02 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £300,000 being liability of woodsford property (bristol) limited of £2,810,000
    Breve descripción
    B & q warehouse unit carmarthen road swansea.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 02 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 29 oct 1993
    Entregado el 05 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All the rents licence fees & other monies receivable under the lease dated 17/11/88. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 05 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 oct 1993
    Entregado el 05 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £2,280,000 & all other monies due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H property k/a the b & q warehouse unit carmarthen road swansea t/no WA352041 with a floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 05 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0