VICTREX SALES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVICTREX SALES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02845021
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VICTREX SALES LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra VICTREX SALES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VICTREX SALES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LAPISCREST LIMITED16 ago 199316 ago 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VICTREX SALES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VICTREX SALES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 25 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 mar 2011

    Estado de capital el 17 mar 2011

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 sept 2010 au 31 dic 2010

    3 páginasAA01

    Nombramiento de Mr Peter Edward Bream como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Peacock como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr David Richard Hummel el 30 jun 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Michael William Peacock el 30 jun 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Timothy Walker como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr David Richard Hummel el 18 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Dr Timothy John Walker el 18 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Michael William Peacock el 18 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Gary Michael Hulme el 18 nov 2009

    1 páginasCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2008

    11 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288b

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2007

    12 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2006

    13 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2005

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de VICTREX SALES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HULME, Gary Michael
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Secretario
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    English73159370002
    BREAM, Peter Edward
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Director
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBritish77236000001
    HUMMEL, David Richard
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Director
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    UsaAmerican34531900003
    BUTTERWORTH, Howard Alan
    Cartref 63 Manor Road
    BH31 6DT Verwood
    Dorset
    Secretario
    Cartref 63 Manor Road
    BH31 6DT Verwood
    Dorset
    British36244060001
    PEACOCK, Michael William
    Honeywood House
    The Sands Woodborough
    SN9 5PU Pewsey
    Wiltshire
    Secretario
    Honeywood House
    The Sands Woodborough
    SN9 5PU Pewsey
    Wiltshire
    British42159970009
    TILSTON, David Frank
    The Orchard
    1 Hare Lane
    KT10 9BT Claygate
    Surrey
    Secretario
    The Orchard
    1 Hare Lane
    KT10 9BT Claygate
    Surrey
    British157476100001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BUTTERWORTH, Howard Alan
    Cartref 63 Manor Road
    BH31 6DT Verwood
    Dorset
    Director
    Cartref 63 Manor Road
    BH31 6DT Verwood
    Dorset
    British36244060001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Director designado
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    PEACOCK, Michael William
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Director
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    United KingdomBritish42159970011
    REIMER, Wolfgang
    Am Rockerkopf 6a
    65719 Hofheim
    Germany
    Director
    Am Rockerkopf 6a
    65719 Hofheim
    Germany
    German37647660001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Director designado
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    ROWLEY, Peter John, Dr
    Swiss Lodge
    Salt Cotes Road
    FY8 4LL Lytham St Annes
    Lancashire
    Director
    Swiss Lodge
    Salt Cotes Road
    FY8 4LL Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritish34531930002
    SYMS, Paul Jeremy Charles
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    Director
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    British34531910002
    TILSTON, David Frank
    The Orchard
    1 Hare Lane
    KT10 9BT Claygate
    Surrey
    Director
    The Orchard
    1 Hare Lane
    KT10 9BT Claygate
    Surrey
    EnglandBritish157476100001
    WALKER, Timothy John, Dr
    2 Linnet Lane
    FY8 4AJ Lythams St Annes
    Lancashire
    Director
    2 Linnet Lane
    FY8 4AJ Lythams St Annes
    Lancashire
    United KingdomBritish64199720001

    ¿Tiene VICTREX SALES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 29 nov 1995
    Entregado el 15 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 sept 1993
    Entregado el 18 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with each of the credit agreements and other financing documents and/or this debenture
    Breve descripción
    (For full details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Agent for Itself and the Secured Parties
    Transacciones
    • 18 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 06 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0