POLO COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | POLO COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02845397 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de POLO COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
- Otras actividades auxiliares a los seguros y a la financiación de pensiones (66290) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra POLO COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 'Grange Park' Bishop's Cleeve GL52 8YQ Cheltenham United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de POLO COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CAPITA COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED | 05 jul 2007 | 05 jul 2007 |
| CLAIMS MANAGEMENT GROUP LIMITED | 02 oct 1998 | 02 oct 1998 |
| IRISC LIMITED | 12 dic 1995 | 12 dic 1995 |
| IRISC LONDON LIMITED | 17 ago 1993 | 17 ago 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de POLO COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para POLO COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para POLO COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 28 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Ms Stella Elizabeth Beaumont el 07 ago 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Matthew James Bishop como director el 31 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Gareth Howard John Nokes como director el 20 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Modification des détails de Marco Capital Holdings (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 nov 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 27 páginas | AA | ||
Nombramiento de Adenike Oluwatobi Meadows como secretario el 15 ago 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Michael Laws como director el 26 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Paul Ian Wooldridge el 03 abr 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Jeremy Hardwicke Riley el 03 abr 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Richard Frederick Lawson el 03 abr 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Dr Peter Michael Laws el 03 abr 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Richard Daniel Coughlin el 03 abr 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Paul David Andrews el 03 abr 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Ms Stella Elizabeth Beaumont como director el 14 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 'the Grange’ Cheltenham Gloucs GL52 8YQ United Kingdom a 'Grange Park' Bishop's Cleeve Cheltenham GL52 8YQ el 09 feb 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Matthew James Bishop como director el 29 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 65 Gresham Street London EC2V 7NQ England a 24 Monument Street London EC3R 8AJ | 1 páginas | AD02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Hackwood Secretaries Limited como secretario el 30 jun 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Jeremy Hardwick Riley como director el 05 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Hackwood Secretaries Limited One Silk Street London EC2Y 8HQ United Kingdom a 'the Grange’ Cheltenham Gloucs GL52 8YQ el 23 may 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
¿Quiénes son los directivos de POLO COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEADOWS, Adenike Oluwatobi | Secretario | Monument Street 4th Floor EC3R 8AJ London 24 United Kingdom | 326204730001 | |||||||||||
| ANDREWS, Paul David | Director | Bishop's Cleeve GL52 8YQ Cheltenham 'Grange Park' United Kingdom | United Kingdom | British | 309020060001 | |||||||||
| COUGHLIN, Richard Daniel | Director | Bishop's Cleeve GL52 8YQ Cheltenham 'Grange Park' United Kingdom | England | British | 286079390001 | |||||||||
| LAWSON, Richard Frederick | Director | Bishop's Cleeve GL52 8YQ Cheltenham 'Grange Park' United Kingdom | United Kingdom | British | 305133850001 | |||||||||
| NOKES, Gareth Howard John | Director | Bishop's Cleeve GL52 8YQ Cheltenham 'Grange Park' United Kingdom | England | British | 275660780002 | |||||||||
| RILEY, Jeremy Hardwicke | Director | Bishop's Cleeve GL52 8YQ Cheltenham 'Grange Park' United Kingdom | England | British | 151652370001 | |||||||||
| WEDDERBURN, Stella Elizabeth | Director | Bishop's Cleeve GL52 8YQ Cheltenham 'Grange Park' United Kingdom | United Kingdom | British | 238293090004 | |||||||||
| WOOLDRIDGE, Paul Ian | Director | Bishop's Cleeve GL52 8YQ Cheltenham 'Grange Park' United Kingdom | England | British | 217711960002 | |||||||||
| MORGAN, Richard Trevor Antony | Secretario | 23 Ravenscourt Park W6 0TJ London | British | 46742550001 | ||||||||||
| PIGRAM, Ivor | Secretario | 93 Kingsfield Road Oxhey WD19 4TP Watford Hertfordshire | British | 993440001 | ||||||||||
| CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | The Registry 34 Beckenham Road BR3 4TU Beckenham Kent | 102944500001 | |||||||||||
| CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Gresham Street EC2V 7NQ London 65 England |
| 138426340001 | ||||||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | One Silk Street EC2Y 8HQ London C/O Hackwood Secretaries Limited United Kingdom |
| 147306890001 | ||||||||||
| ASHBURN, Christopher Stuart | Director | EC2V 7NQ London 65 Gresham Street England | England | British | 331716020001 | |||||||||
| BARNES, Simon Royston | Director | Rochester Row Westminster SW1P 1QT London 17 England | United Kingdom | British | 54816310001 | |||||||||
| BEDFORD, Nicolas Norman | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 147404780001 | |||||||||
| BEER, Andrew John | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 129144740001 | |||||||||
| BISHOP, Matthew James | Director | Bishop's Cleeve GL52 8YQ Cheltenham 'Grange Park' United Kingdom | England | British | 283106370001 | |||||||||
| BISSELL, John Charles | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 England | England | British | 166676700001 | |||||||||
| BORD, Andrew | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 188214400001 | |||||||||
| BOWMAN, Andrew John | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 190287270001 | |||||||||
| CALLAHAN, Charles Edward | Director | 25 Sutton Place South Ph (A) NY10022 New York Usa | American | 61241020002 | ||||||||||
| CARTER, Gregson James Grierson | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 England | United Kingdom | British | 166676730001 | |||||||||
| CHOPOURIAN, Arthur Giragos | Director | Doone Cottage Church Walk Wilmington DA2 7EL Dartford Kent | United Kingdom | British | 166350280001 | |||||||||
| CLEMENTS, Karen Suzanne | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 160392210001 | |||||||||
| COLLS, Alan Howard Crawfurd | Director | 23 Victoria Road W8 5RF London | British | 7611780002 | ||||||||||
| CONBOY, Philip Richard | Director | 16 Dudley Road SW19 8PN London | United Kingdom | Irish | 141579680001 | |||||||||
| COX, Timothy Michael | Director | Five Acres St Johns Road Oakley RG23 7DX Basingstoke Hampshire | England | British | 43745170001 | |||||||||
| COX, Timothy Michael | Director | Five Acres St Johns Road Oakley RG23 7DX Basingstoke Hampshire | England | British | 43745170001 | |||||||||
| CREASY, Edward George | Director | Rochester Row Westminster SW1P 1QT London 17 | United Kingdom | British | 11594070002 | |||||||||
| EISENMANN, Stephen | Director | Irisc 8 Centre Drive Jamesburg New Jersey FOREIGN Usa | American | 36244180001 | ||||||||||
| ESCOTT, Brent | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 53228400003 | |||||||||
| FINLAY, William David | Director | Rochester Row Westminster SW1P 1QT London 17 England | England | British | 135535110001 | |||||||||
| FULLER, Andrew Jonathan | Director | Woodland Park Whalley BB7 9UG Lancashire 28 | British | 132077340001 | ||||||||||
| GREATOREX, Anthony Nicholas | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 90617270001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de POLO COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Capital Holdings (Uk) Limited | 29 abr 2022 | Monument Street, 4th Floor EC3R 8AJ London 24 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Capita Insurance Services Holdings Limited | 06 abr 2016 | Gresham Street EC2V 7NQ London 65 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0