REFINED MP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaREFINED MP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02847780
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de REFINED MP LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra REFINED MP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Hertfordshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REFINED MP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MALTHURST PETROLEUM LIMITED21 jun 200021 jun 2000
    GILLINGHAM SERVICE STATION LIMITED22 oct 199822 oct 1998
    HEARTS SERVICES LIMITED25 ago 199325 ago 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de REFINED MP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para REFINED MP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    8 páginasAA

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 30 ago 2019

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of capital redemption reserve 28/08/2019
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Thomas Mckenzie Biggart como director el 11 mar 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Pinsent Masons Secretarial Limited como secretario el 07 mar 2019

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de David Hathaway como secretario el 07 mar 2019

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Graham Paul Timbers como director el 12 feb 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Simon Paul Lane como director el 31 dic 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr William Bahlsen Bannister como director el 31 dic 2018

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU el 02 ene 2019

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Steven John Back como director el 15 oct 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Graham Paul Timbers como director el 12 oct 2018

    2 páginasAP01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2018 au 31 dic 2018

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Karen Juanita Dickens como director el 22 jun 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 01 oct 2017

    7 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2017 au 30 sept 2017

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2017 au 31 dic 2017

    1 páginasAA01

    ¿Quiénes son los directivos de REFINED MP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Secretario corporativo
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02318923
    76579530001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Director
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish252731900001
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Director
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    ScotlandBritish215843640001
    LANE, Simon Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Director
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish252862090001
    BIRD, Edwin Arthur
    Hulver
    Dane O'Coys Road
    CM23 2JP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secretario
    Hulver
    Dane O'Coys Road
    CM23 2JP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British55967160001
    CAMPBELL, James Oliver
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    Secretario
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    British29587680003
    DOWDING, Charles Michael
    1 Oakcroft Drive
    Framingham Earl
    NR14 7JQ Norwich
    Norfolk
    Secretario
    1 Oakcroft Drive
    Framingham Earl
    NR14 7JQ Norwich
    Norfolk
    British13193130001
    FRENCH, Walter
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    Secretario
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    British88005070001
    HATHAWAY, David
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Secretario
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    British117227730001
    KEATING, Roderick Charles
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Secretario
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    British126363230002
    KEIDAN, Michael David Alan
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Secretario
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Other1447490001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BACK, Steven John
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Director
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish205661380001
    CAMPBELL, James Oliver
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    Director
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    United KingdomBritish29587680003
    DICKENS, Karen Juanita, Dr
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Director
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish124061360001
    FRENCH, Walter
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    Director
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    EnglandBritish88005070001
    KING, Joseph
    Stratford House
    Stratford Crescent
    NR4 7SF Cringleford
    Norfolk
    Director
    Stratford House
    Stratford Crescent
    NR4 7SF Cringleford
    Norfolk
    British3635770001
    PEACOCK, Graham Frederick
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Director
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish5133310002
    PEACOCK, Graham Frederick
    5 Brook Street
    Little Dunmow
    CM6 3HU Dunmow
    Essex
    Director
    5 Brook Street
    Little Dunmow
    CM6 3HU Dunmow
    Essex
    British5133310001
    PEARS, David Alan
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Director
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    EnglandBritish65200910001
    PEARS, Mark Andrew
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Director
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    EnglandBritish1447500008
    PEARS, Trevor Steven, Sir
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Director
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    EnglandBritish40036010005
    ROBINSON, Melvin Frank
    19 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    Director
    19 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish146452070001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Director
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    EnglandBritish107002130001
    SHARPE, Steven
    Kenwood House
    Kenwood Close
    NW3 7JL London
    Director
    Kenwood House
    Kenwood Close
    NW3 7JL London
    EnglandBritish146452160001
    THOMPSON, Brian Lane
    Rock Hill House Rock Hill
    OX7 5BA Chipping Norton
    Oxfordshire
    Director
    Rock Hill House Rock Hill
    OX7 5BA Chipping Norton
    Oxfordshire
    British56518620001
    TIMBERS, Graham Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Director
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish127888240001
    TOBBELL, Susan Margaret
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Director
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish17957620003
    TOBBELL, Susan Margaret
    The Finch Inn Church Hill
    Finchingfield
    CM7 4NN Essex
    Director
    The Finch Inn Church Hill
    Finchingfield
    CM7 4NN Essex
    United KingdomBritish17957620003
    WPG REGISTRARS LIMITED
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Director corporativo
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    106986280001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de REFINED MP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Refined Estates Limited
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    06 abr 2016
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro04193995
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene REFINED MP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rental assignation
    Creado el 11 ene 2005
    Entregado el 21 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and refined estates limited to the chargee
    Breve descripción
    The benefit of all rents payable under the lease entered into between malthurst petroleum limited, malthurst fuels limited and malthurst UK limited dated 17 november 2003, together with such arrears (if any), including (without limitation) all vat (if any) payable on or in respect of the same. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 21 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 dic 2004
    Entregado el 23 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Banking Corporation PLC
    Transacciones
    • 23 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 21 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2005 and
    Creado el 15 dic 2004
    Entregado el 25 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and whole subjects k/a milngavie service station, glasgow road, milngavie t/n DMB4074.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 25 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 feb 2002
    Entregado el 26 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property known as 457 alfreton road nottingham.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 11 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 jul 2001
    Entregado el 30 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property k/a little london service station london road spalding lincolnshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 10 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 may 2001
    Entregado el 31 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Leasehold property being land and buildings on the south side of norwich road gillingham.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 11 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 may 2001
    Entregado el 24 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee including all such monies as may fall due for payment under any agreements present and future all costs and expenses all sums due for any goods or services supplied by the chargee to the company, any interest payable to the chargee by the company, or sums which become due to the chargee in connection with any loan, and all sums which become due to the chargee in connection with an externally funded loan
    Breve descripción
    Premises k/a widows cruse filling station gillinham nr beccles norfolk all fixtures and fittings not being personal chattels within the bill of sales act on the premises, all rental income present or future and whether payable now or in the future and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bp Oil UK Limited
    Transacciones
    • 24 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 11 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 may 2001
    Entregado el 30 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 10 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 21 june 2001 and
    Creado el 18 may 2001
    Entregado el 26 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Milngavie service station, 42 glasgow road, milngavie.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 10 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 feb 1996
    Entregado el 28 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a petrol filling station at junction of A143/A146 roads gillingham near beccles norfolk together with all fixtures and fittings at any tim at the property the benefits of all rights licences and the goodwill of the company at the premises.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 28 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 feb 1996
    Entregado el 28 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    L/H property k/a petrol filling station junction A143/A146 roads gillingham nr. Beccles norfolk together with all fixtures fittings at the premises all rental income at any time all rights and claims against any third parties all goodwill full benefit of all contracts of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mobil Oil Company Limited
    Transacciones
    • 28 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge and assignment
    Creado el 19 ene 1995
    Entregado el 23 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Petrol filling station development site situate at the junction of A143 and A146 gillingham norfolk all and singular the mortgagor's respective rights title and interest in and to each of the development documents and the development. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mobil Oil Company Limited
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 23 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 03 jun 1994
    Entregado el 10 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0