TWEED PREMIER 3 LIMITED

TWEED PREMIER 3 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTWEED PREMIER 3 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02847988
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    • (7011) /

    ¿Dónde se encuentra TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FUTURECOIN PUBLIC LIMITED COMPANY25 ago 199325 ago 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Andrew Jones como director

    1 páginasTM01

    Estado de capital el 15 abr 2010

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    3 páginasMG02

    Cese del nombramiento de Timothy Roberts como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nigel Webb como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Taylor como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Lucinda Bell como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Clarke como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sarah Barzycki como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del secretario Ndiana Ekpo el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    19 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    19 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    19 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    3 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de TWEED PREMIER 3 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Director
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    BLACK, Lysanne Jane Warren
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    Secretario
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    British46707740002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Secretario
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    British59208430002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Secretario
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    British59208430002
    CHILDS, Lisbeth Ann, Doctor
    17 Gay Street
    BA1 2PH Bath
    Avon
    Secretario
    17 Gay Street
    BA1 2PH Bath
    Avon
    British50515040002
    DIMENT, Peter Charles Michael
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secretario
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British32770400001
    DOWDESWELL, Jacqueline Anne
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    Secretario
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    British50592080001
    GULHANE, Angeli Asha
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    Secretario
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    British38173040001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Secretario
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    British106162380001
    MACRAE, Alistair Ian
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    British71950710001
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Secretario
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British47952140001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    THE BRITISH LINEN BANK LIMITED
    4 Melville Street
    EH3 7NZ Edinburgh
    Midlothian
    Secretario corporativo
    4 Melville Street
    EH3 7NZ Edinburgh
    Midlothian
    41450001
    BALLINGALL, Stuart James
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Director
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British57693580001
    BAMBER, Roger Stanley
    Whithorne Coach House
    London Road Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Whithorne Coach House
    London Road Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish2419370002
    BARKLEY, John
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    Director
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    British18955940002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Director
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Director
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritish32809050004
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Director
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    United KingdomBritish59208430002
    CASSELS, Alexander
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    British566790001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    COLLINS, Roger
    3 Hann Close
    BA5 2JR Wells
    Somerset
    Director
    3 Hann Close
    BA5 2JR Wells
    Somerset
    British45885520003
    CRUICKSHANK, James Kerr
    3 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    Director
    3 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    British46894940001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    Director
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    British36631180001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish106162380001
    HUNTER, John Stewart
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    Director
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    ScotlandBritish1127070001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Director
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MURRAY, Edward Davidson
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish504780001
    ONEIL, James Charles
    12 Antigua Street
    EH1 3NH Edinburgh
    Director
    12 Antigua Street
    EH1 3NH Edinburgh
    British63521290001
    RADLEY, Alan John
    35 Beaconsfield Way
    BA11 2UD Frome
    Somerset
    Director
    35 Beaconsfield Way
    BA11 2UD Frome
    Somerset
    British80260530001
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Director
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish63986410003

    ¿Tiene TWEED PREMIER 3 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 17 sept 2003
    Entregado el 30 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    26 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108953, 16 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108956, 24 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108960 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Creado el 11 sept 2003
    Entregado el 23 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    195 mains drive erskine t/no REN27597 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transacciones
    • 23 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Creado el 11 sept 2003
    Entregado el 23 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    12 the oaks killearn t/no STG10016 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transacciones
    • 23 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 31 dic 2002
    Entregado el 09 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 09 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 dic 2002
    Entregado el 09 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All liabilities and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to the chargee and the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    (I) plot 2,beck riggs,brampton CU108956; (ii) flat 1,23 lansdowne rd,purley; SGL577213; (iii) 51 azalea close,ilford; EGL335123; see form 395 for details. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society,as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transacciones
    • 09 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Creado el 30 dic 2002
    Entregado el 04 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    195 mains drive erskine PA8 7JN title number REN27597.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transacciones
    • 04 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Creado el 30 dic 2002
    Entregado el 04 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    12 the oaks killearn title number STG10016.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transacciones
    • 04 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0