H.B.F. LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | H.B.F. LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02849200 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de H.B.F. LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra H.B.F. LIMITED?
| Dirección de la sede social | Globe Lane Industrial Estate Outram Road SK16 4XE Dukinfield Cheshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de H.B.F. LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| H.B. FULLER U.K. LIMITED | 23 feb 1994 | 23 feb 1994 |
| H.B. FULLER ADHESIVES LIMITED | 18 nov 1993 | 18 nov 1993 |
| TRUSHELFCO (NO. 1926) LIMITED | 31 ago 1993 | 31 ago 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de H.B.F. LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 nov 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para H.B.F. LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 may 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Datac Adhesives Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 may 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de H.B. Fuller U.K. Operations Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 may 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Estado de capital el 19 may 2022
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 nov 2021 au 30 may 2022 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 nov 2020 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2019 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr. Emilio Roque Vilas el 12 may 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 01 dic 2018 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Citco Management Uk Ltd como secretario el 01 nov 2018 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 02 dic 2017 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 may 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Hb Fuller Uk Operations en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 jul 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms. Heidi Ann Weiler el 10 jul 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Emilio Roque Vilas el 10 jul 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de H.B.F. LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO MANAGEMENT UK LTD | Secretario corporativo | Albemarle Street W1S 4HQ London 7 United Kingdom |
| 252274080001 | ||||||||||
| MARTSCHING, Robert Joseph | Director | Globe Lane Industrial Estate Outram Road SK16 4XE Dukinfield Cheshire | United States | American | 187857740002 | |||||||||
| VILAS, Emilio Roque, Mr. | Director | Globe Lane Industrial Estate Outram Road SK16 4XE Dukinfield Cheshire | Spain | Spanish | 229774500003 | |||||||||
| WEILER, Heidi Ann, Ms. | Director | Globe Lane Industrial Estate Outram Road SK16 4XE Dukinfield Cheshire | United States | American | 239047270001 | |||||||||
| BUTENSCHON, Peter | Secretario | Kronskamp 5 21339 Luneburg | British | 40745530001 | ||||||||||
| DAVIES, Nigel Richard | Secretario | 19 Leigh Road K10 4HX Prestbury Cheshire Cheshire | British | 104628430001 | ||||||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom |
| 73539350001 | ||||||||||
| TRUSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | 900007200001 | |||||||||||
| BAKER, Richard C | Director | 2444 West 24th Street Minneapolis Minnesota 55405 Usa | American | 39101980001 | ||||||||||
| BOLANOS, Jorge Walter | Director | 2 Doral Road Dellwood Minnesota 55110 Usa | Costa Rican | 40557020001 | ||||||||||
| CHANDLER, Christine Anne | Director designado | 31 Chesnut Grove New Malden Surrey | British | 900007180001 | ||||||||||
| CHAPMAN, Nicholas Craig | Director | 69 Cosgrove Avenue Skegby NG17 3JY Sutton In Ashfield Nottinghamshire | British | 79990990001 | ||||||||||
| CONATY, James R | Director | 733 Cranbrook Road Bloomfield Hills 48301 Michigan 48301 Usa | American | 94344950001 | ||||||||||
| DAVIES, Nigel Richard | Director | 19 Leigh Road K10 4HX Prestbury Cheshire Cheshire | England | British | 104628430001 | |||||||||
| EVANS, Grenville Alun | Director | 72 Camberley Drive OL11 4BA Rochdale Lancashire | England | British | 77471580001 | |||||||||
| JONES, Paul Marshall | Director | Little Orchard Bacombe Lane HP22 6EQ Wendover Buckinghamshire | British | 59474120001 | ||||||||||
| KISSLING, Walter | Director | 23 Oriole Lane North Oaks Minnesota 55127 Usa | Costa Rican | 40557540001 | ||||||||||
| KOXHOLT, Peter Manfred | Director | 1440 Donegal Drive Woodbury Minnesota 55125 Usa | German | 64355950002 | ||||||||||
| LAGALLY, Hermann Wolfgang, Dr | Director | Schafwiesenstr 70 A-4600 Wels Austria | German | 59053780001 | ||||||||||
| LEES, Brian | Director | 9b Ridge Avenue Marple SK6 7HJ Stockport Cheshire | British | 60016130001 | ||||||||||
| MCCREARY JR, James C | Director | Kilt Court Hudson 762 Wisconsin 54016 Usa | Usa | American | 129024790002 | |||||||||
| MCNELLIS, William Albart | Director | Yew Tree Lodge Northwood Lane DE4 Darley Dale Derbyshire | American | 7081890001 | ||||||||||
| MORETTI, Monica | Director | 11205 Halstead Trail Woodbury Minnesota 55129 United States | Italian | 120822170002 | ||||||||||
| REEVE, Robert Arthur | Director designado | 6 Wellesford Close SM7 2HL Banstead Surrey | British | 900007190001 | ||||||||||
| REINITZ, Cheryl Ann | Director | 15420 Norell Avenue North Marine On St Croix Minnesota 55047 United States | United States | American | 120824200001 | |||||||||
| RIVERS, David Edward | Director | 54 Peters Avenue LE9 9PR Newbold Verdon Leicestershire | British | 91351350001 | ||||||||||
| RODRIGUEZ ZAMORA, Marco Vinicio | Director | Apartment 1 St. James Court 4 Moorland Road M20 6AZ Manchester | Costa Rican | 84880630001 | ||||||||||
| SCOTT, Jerald | Director | 1124 Amble Drive Arden Hills Minnesota Usa | American | 40559050002 | ||||||||||
| TAYLOR, Nicholas Robert | Director | 9 Fairisle Close Oakwood DE21 2SJ Derby Derbyshire | England | British | 112361980001 | |||||||||
| VOLPI, Michelle | Director | 9347 Wedgewood Drive Woodbury Minnesota 55125 United States | Italian | 104354140001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de H.B.F. LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datac Adhesives Limited | 20 may 2022 | Outram Road SK16 4XE Dukinfield Globe Lane Industrial Estate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| H.B. Fuller U.K. Operations Limited | 06 abr 2016 | Outram Road SK16 4XE Dukinfield Globe Lane Industrial Estate United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene H.B.F. LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Creado el 02 sept 1998 Entregado el 17 sept 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge | |
Breve descripción By way of legal mortgage all that the mortgaged property meaning all that property as is described in schedule 1 as nil, together with all fixed plant and machinery and fixtures thereto and all and any proceeds of sale of all or any part thereof and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title together with any moneys payable in respect of such covenants.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0