PARDEV (LUTON) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PARDEV (LUTON) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02849784 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PARDEV (LUTON) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ONETRADE LIMITED | 01 sept 1993 | 01 sept 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2019 | 14 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 206 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Segunda presentación para la terminación de Benjamin Toby Grose como director | 5 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 10 abr 2018 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Bruce Michael James como director el 10 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip John Martin como director el 31 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip John Martin como secretario el 31 oct 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de British Land Company Secretarial Limited como secretario el 31 oct 2016 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Charles John Middleton como director el 13 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Jonathan Charles Mcnuff como director el 13 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| MARTIN, Philip John | Secretario | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | British | 35118050001 | ||||||||||
| PEARSON, William | Secretario | 12 Hamilton Close SE16 1QJ London | British | 206426340001 | ||||||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Secretario designado corporativo | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 | |||||||||||
| BERESFORD, Valentine Tristram | Director | 3 Smith Terrace SW3 4DL London | England | British | 40766290003 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| MARTIN, Philip John | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 35118050001 | |||||||||
| MAXTED, Robert David | Director | Vanhurst Thorncombe Street GU5 0ND Bramley Surrey | British | 37177990001 | ||||||||||
| MCGANN, Martin Francis | Director | 10 Westcombe Park Road SE3 7RB Blackheath London | British | 109383240001 | ||||||||||
| MOULD, Harold Raymond | Director | 40 Hasker Street SW3 2LQ London | England | British | 35576350006 | |||||||||
| PEARSON, William | Director | 12 Hamilton Close SE16 1QJ London | England | British | 206426340001 | |||||||||
| PRICE, Humphrey James Montgomery | Director | Deaks Deaks Lane RH17 5JA Cuckfield West Sussex | Uk | British | 14448630001 | |||||||||
| SHEEN, Richard Keith | Director | 53 Elystan Place SW3 3JY London | British | 49750560001 | ||||||||||
| SMITH, Andrew David | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 108214880002 | |||||||||
| STIRLING, Mark Andrew | Director | Great Oak House Essendon Place, Essendon AL9 6GZ Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | 106882210001 | |||||||||
| VAUGHAN, Patrick Lionel | Director | June Farm Trumpet Hill Road RH2 8QY Reigate Surrey | United Kingdom | British | 73972350001 | |||||||||
| NOROSE LIMITED | Director designado corporativo | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006410001 | |||||||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Director designado corporativo | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PARDEV (LUTON) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillar Property Group Limited | 06 abr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene PARDEV (LUTON) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over rent deposit account | Creado el 23 ene 1998 Entregado el 03 feb 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and schildvink B.V. (together the borrower) to the chargee and their respective successors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner | |
Breve descripción All sims from time to time standing to the credit of the borrower in the account number 00214912 in the name of the borrower held with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 23 ene 1998 Entregado el 03 feb 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and schildvink B.V.(together the borrower) to the chargee and their respective sucessors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner | |
Breve descripción The f/h property k/a units 400,450 and 475 capability green luton t/n BD164321 with all machinery buildings or other erections any sum paid under any insurance policy any deposit paid of any estate or interest in whole or in part of the property & other assets please refer to form 395 for full details and by way of floating charge all undertaking property and assets of the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over acv deposit account | Creado el 23 ene 1998 Entregado el 03 feb 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The provisions of clause 12.1.17 of the facility agreement dated 21ST december 1993 made between pillar property PLC,pardev (luton) limited and wurttembergische hypothekenbank ag (as agent and trustee for the lender as defined)and their respective successors and assigns and to those deriving title through or under them (together the "lender") as varied by a first variation agreement dated 10TH june 1994 and as amended and restated by a second variation agreement dated 21ST january 1998 and any subsequent variation and amendment to that agreement provides that it will be an event of default under the facility agreement if certain loan-to-loan requirements are not met unless the company repays part of the loan or provides further security or pays money into the account | |
Breve descripción All sums standing to the credit of the company in an account numbered 00214920 held in the name of the company with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 23 dic 1993 Entregado el 06 ene 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a units 1,100,400,450 and 475 capability green luton t/NOSBD145653,BD132562 and BD164321 and all rents receivable and by way of floating charge all undertaking and property of the borrower. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over acv deposit account | Creado el 23 dic 1993 Entregado el 06 ene 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of clause 12.1.17 of a facility agreement dated 21ST december 1993 | |
Breve descripción Assignment of all sums from time to time standing to the credit of the company in the acxcount numbered 1528002 at the bank of scotland. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over rent deposit | Creado el 23 dic 1993 Entregado el 06 ene 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in a facility agreement dated 21ST december 1993 | |
Breve descripción Assignment by way of security of all sums from time to time standing to the credit of the company in current account number 623461. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0