PARDEV (LUTON) LIMITED

PARDEV (LUTON) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPARDEV (LUTON) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02849784
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PARDEV (LUTON) LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ONETRADE LIMITED01 sept 199301 sept 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2019

    14 páginasAA

    legacy

    206 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Segunda presentación para la terminación de Benjamin Toby Grose como director

    5 páginasRP04TM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 10 abr 2018

    2 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    14 may 2018Clarification A second filed TM01 was registered on 14/05/2018

    Nombramiento de Mr Bruce Michael James como director el 10 abr 2018

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Philip John Martin como director el 31 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Philip John Martin como secretario el 31 oct 2016

    1 páginasTM02

    Nombramiento de British Land Company Secretarial Limited como secretario el 31 oct 2016

    2 páginasAP04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Charles John Middleton como director el 13 jul 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Jonathan Charles Mcnuff como director el 13 jul 2016

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 sept 2015

    Estado de capital el 22 sept 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro8992198
    187856670001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    MARTIN, Philip John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Secretario
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British35118050001
    PEARSON, William
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    Secretario
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    British206426340001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Secretario designado corporativo
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Director
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritish40766290003
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35118050001
    MAXTED, Robert David
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    Director
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    British37177990001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Director
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    British109383240001
    MOULD, Harold Raymond
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    Director
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    EnglandBritish35576350006
    PEARSON, William
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    Director
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    EnglandBritish206426340001
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Director
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritish14448630001
    SHEEN, Richard Keith
    53 Elystan Place
    SW3 3JY London
    Director
    53 Elystan Place
    SW3 3JY London
    British49750560001
    SMITH, Andrew David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish108214880002
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106882210001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Director
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish73972350001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Director designado corporativo
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Director designado corporativo
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PARDEV (LUTON) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Pillar Property Group Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene PARDEV (LUTON) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over rent deposit account
    Creado el 23 ene 1998
    Entregado el 03 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and schildvink B.V. (together the borrower) to the chargee and their respective successors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner
    Breve descripción
    All sims from time to time standing to the credit of the borrower in the account number 00214912 in the name of the borrower held with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    Transacciones
    • 03 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 ene 1998
    Entregado el 03 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and schildvink B.V.(together the borrower) to the chargee and their respective sucessors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner
    Breve descripción
    The f/h property k/a units 400,450 and 475 capability green luton t/n BD164321 with all machinery buildings or other erections any sum paid under any insurance policy any deposit paid of any estate or interest in whole or in part of the property & other assets please refer to form 395 for full details and by way of floating charge all undertaking property and assets of the company.
    Personas con derecho
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    Transacciones
    • 03 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over acv deposit account
    Creado el 23 ene 1998
    Entregado el 03 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The provisions of clause 12.1.17 of the facility agreement dated 21ST december 1993 made between pillar property PLC,pardev (luton) limited and wurttembergische hypothekenbank ag (as agent and trustee for the lender as defined)and their respective successors and assigns and to those deriving title through or under them (together the "lender") as varied by a first variation agreement dated 10TH june 1994 and as amended and restated by a second variation agreement dated 21ST january 1998 and any subsequent variation and amendment to that agreement provides that it will be an event of default under the facility agreement if certain loan-to-loan requirements are not met unless the company repays part of the loan or provides further security or pays money into the account
    Breve descripción
    All sums standing to the credit of the company in an account numbered 00214920 held in the name of the company with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    Transacciones
    • 03 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 dic 1993
    Entregado el 06 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a units 1,100,400,450 and 475 capability green luton t/NOSBD145653,BD132562 and BD164321 and all rents receivable and by way of floating charge all undertaking and property of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag
    Transacciones
    • 06 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 10 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over acv deposit account
    Creado el 23 dic 1993
    Entregado el 06 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of clause 12.1.17 of a facility agreement dated 21ST december 1993
    Breve descripción
    Assignment of all sums from time to time standing to the credit of the company in the acxcount numbered 1528002 at the bank of scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag (As Agent)
    Transacciones
    • 06 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 10 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over rent deposit
    Creado el 23 dic 1993
    Entregado el 06 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in a facility agreement dated 21ST december 1993
    Breve descripción
    Assignment by way of security of all sums from time to time standing to the credit of the company in current account number 623461. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag
    Transacciones
    • 06 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 10 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0