REXEL UK HOLDINGS LIMITED

REXEL UK HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaREXEL UK HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02852274
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de REXEL UK HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra REXEL UK HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REXEL UK HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HAGEMEYER (UK) HOLDINGS LIMITED06 sept 199306 sept 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de REXEL UK HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para REXEL UK HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    17 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor, Eagle Court 2 Hatchford Brook Hatchford Way Sheldon Birmingham B26 3RZ England a C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH el 14 mar 2022

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    7 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 24 feb 2022

    LRESSP

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Estado de capital el 18 nov 2021

    • Capital: EUR 0.90
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce hare prem a/c 17/11/2021
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 06 sept 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    16 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Toby James Train el 29 jul 2021

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    16 páginasAA

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 11 dic 2020

    • Capital: EUR 281,642,442.75
    • Capital: GBP 110,000,002
    3 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 06 sept 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Marcus Leek como director el 01 dic 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Christopher James Hogan como director el 01 dic 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 06 sept 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 sept 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    15 páginasAA

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 22 dic 2017

    • Capital: EUR 281,642,442.75
    • Capital: GBP 30,000,002
    3 páginasSH01

    ¿Quiénes son los directivos de REXEL UK HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LEEK, Marcus
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Director
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    EnglandBritish236640560001
    TRAIN, Toby James
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Director
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    EnglandBritish197366610002
    FORRESTER, Andrew John
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Secretario
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    British97001960001
    HAYWOOD, Timothy Paul
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    Secretario
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    British62962370002
    MANDERS, Ivo Hyacinthe Henri Joseph Marie
    Onder Den Dael 10
    1261 Cn
    1261 CN Blaricum
    Netherlands
    Secretario
    Onder Den Dael 10
    1261 Cn
    1261 CN Blaricum
    Netherlands
    Dutch36067020002
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Secretario
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Scottish146642810001
    PASSMAN, Jonathan Richard
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    Secretario
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    British122460330002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BETSCH, Philip Anthony
    Herdersweg 22
    FOREIGN 1251 Er Laren
    Netherlands
    Director
    Herdersweg 22
    FOREIGN 1251 Er Laren
    Netherlands
    American16623180001
    BIRNER, Hendrikus Johannes Jacobus
    Nwe Blaricummerweg 17
    FOREIGN Huizen
    Noord Holland
    The Netherlands
    Director
    Nwe Blaricummerweg 17
    FOREIGN Huizen
    Noord Holland
    The Netherlands
    Dutch47545830001
    BURR, Anthony Hugh
    Woodend House
    33 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    Director
    Woodend House
    33 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    British986020002
    CROXSON, Neil Michael
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    United Kingdom
    UkBritish96469690005
    DE GRAAF, Hendrik Jacobus
    Kleverheim
    Krachtighuizerweg 19
    FOREIGN Putten 3881 Pc
    The Netherlands
    Director
    Kleverheim
    Krachtighuizerweg 19
    FOREIGN Putten 3881 Pc
    The Netherlands
    Dutch49675460001
    FORRESTER, Andrew John
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Director
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    United KingdomBritish97001960001
    FRASER, Angus Maclean
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Irish70451130001
    HAMMERSCHMID, Thomas
    86 Centenary Plaza
    Holliday Street
    B1 1HH Birmingham
    West Midlands
    Director
    86 Centenary Plaza
    Holliday Street
    B1 1HH Birmingham
    West Midlands
    Austrian114541610001
    HAYWOOD, Timothy Paul
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    Director
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritish62962370002
    HIGGERSON, Richard Joseph
    Oud Huizerweg 17
    1261 Bd Blaricum
    FOREIGN The Netherlands
    Director
    Oud Huizerweg 17
    1261 Bd Blaricum
    FOREIGN The Netherlands
    American43694760002
    HOGAN, John Christopher James
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    Potters Bar
    5th
    Herts
    Director
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    Potters Bar
    5th
    Herts
    United KingdomIrish197357940001
    HOWGATE, John Matthew
    Bay Tree Cottage
    The Street
    RH14 0PT Plaistow
    West Sussex
    Uk
    Director
    Bay Tree Cottage
    The Street
    RH14 0PT Plaistow
    West Sussex
    Uk
    British36067010001
    JISKOOT, Wilco Gustaaf
    Jordaan 15
    1251PB 1251 Pblaren
    Netherlands
    Director
    Jordaan 15
    1251PB 1251 Pblaren
    Netherlands
    Dutch33931260001
    KNAPP, Douglas Murray
    Maurits De Brauwweg 7
    2597 KC The Hague
    The Netherlands
    Director
    Maurits De Brauwweg 7
    2597 KC The Hague
    The Netherlands
    Canadian37239300001
    LASCHKAR, Henri-Paul
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    Director
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    UkFrench139160640005
    MANDERS, Ivo Hyacinthe Henri Joseph Marie
    Utrechtseweg 291
    6865CJ Doorwerth
    Netherlands
    Director
    Utrechtseweg 291
    6865CJ Doorwerth
    Netherlands
    Dutch36067020001
    MANDERS, Ivo Hyacinthe Henri Joseph Marie
    Utrechtseweg 291
    6865CJ Doorwerth
    Netherlands
    Director
    Utrechtseweg 291
    6865CJ Doorwerth
    Netherlands
    Dutch36067020001
    PLUNKETT, Patrick Joseph
    Melrose
    Silchester Road
    IRISH Glenageary
    County Dublin
    Ireland
    Director
    Melrose
    Silchester Road
    IRISH Glenageary
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrish180198160002
    RIDDELL, James Henry
    Noord Crailoseweg 11
    1272 Rd Huilen
    FOREIGN The Netherlands
    Director
    Noord Crailoseweg 11
    1272 Rd Huilen
    FOREIGN The Netherlands
    British46079010003
    STOYEL, Rodney
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    Director
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    British81630780001
    TEVES, Anthony Andre Boris
    Bierweg 14
    126 1BL Blaricum
    The Netherlands
    Director
    Bierweg 14
    126 1BL Blaricum
    The Netherlands
    British41556650001
    TIEMSTRA, Jan Sjoerd Tjalling
    Konijnenlaan 40
    2243 Et Wassenaar
    Netherlands
    Director
    Konijnenlaan 40
    2243 Et Wassenaar
    Netherlands
    Dutch93188850001
    VAN DEN ASSEM, Eduard Henricus Maria
    Irenelaan 34
    5583 AE Waalre
    Netherlands
    Director
    Irenelaan 34
    5583 AE Waalre
    Netherlands
    Dutch69040180001
    WOUTERSE, Alexander Jan
    Van Beeverlaan 15,
    1251 Es Laren
    Netherlands
    Director
    Van Beeverlaan 15,
    1251 Es Laren
    Netherlands
    Dutch105846620001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de REXEL UK HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Rexel Senate Limited
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Eagle Court 2
    England
    30 jun 2016
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Eagle Court 2
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroUk Company Register
    Número de registro02588733
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene REXEL UK HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security over shares agreement
    Creado el 07 nov 2005
    Entregado el 23 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The charged portolio shown on the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V. (As Security Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 23 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 29 oct 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 22 dic 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Disclosed pledge of intercompany receivables
    Creado el 05 feb 2004
    Entregado el 24 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party and from any pledgor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All personal claims of any pledgor against debtors. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V. as Security Agent for the Finance Parties on the Terms and Conditions Setout in the New Facility Agreement
    Transacciones
    • 24 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 29 oct 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 22 dic 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A security over cash agreement
    Creado el 05 feb 2004
    Entregado el 23 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any credit balance from time to time on the accounts listed in schedule 1 (secured accounts) of the security agreement and any future accounts to be opened or maintained by the chargor with the security agent or any other financial institution and all rights benefits and proceeds in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V. as Security Agent for the Finance Parties (The Security Agent)
    Transacciones
    • 23 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 jun 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A security over shares agreement
    Creado el 05 feb 2004
    Entregado el 23 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the shares in the share capital of hagemeyer (UK) limited held by to the order or on behalf of the company at any time and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V. as Security Agent for the Finance Parties (The Security Agent)
    Transacciones
    • 23 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 jun 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene REXEL UK HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    06 ago 2023Fecha prevista de disolución
    24 feb 2022Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Matthew James Chadwick
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Profesional
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Stacey Brown
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profesional
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0