OLD COMPANY 20 LIMITED

OLD COMPANY 20 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOLD COMPANY 20 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02854310
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OLD COMPANY 20 LIMITED?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
    • Reaseguro no de vida (65202) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hampden House
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MS AMLIN LIMITED03 dic 201903 dic 2019
    MS AMLIN PLC29 feb 201629 feb 2016
    AMLIN PLC25 sept 199825 sept 1998
    ANGERSTEIN UNDERWRITING TRUST PLC.30 sept 199330 sept 1993
    HACKPLIMCO (NO.TEN) PUBLIC LIMITED COMPANY17 sept 199317 sept 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Mr Francis William Johnston como director el 01 oct 2020

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 14 oct 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street London EC3V 4AG United Kingdom a Hampden House Great Hampden Great Missenden HP16 9rd el 21 dic 2020

    1 páginasAD01

    Notification de Hampden Group Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2020

    2 páginasPSC02

    Cese del nombramiento de Satoshi Watabe como director el 01 oct 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Shinichi Imayoshi como director el 01 oct 2020

    1 páginasTM01

    Cessation de Ms&Ad Insurance Group Holdings, Inc. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2020

    1 páginasPSC07

    Cese del nombramiento de Frederick Christopher Foreman como secretario el 01 oct 2020

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Frederick Christopher Foreman como director el 01 oct 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Hampden Legal Plc como secretario el 01 oct 2020

    2 páginasAP04

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name14 sept 2020

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 10 sept 2020

    RES15

    Cancelación total de la carga 27

    1 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    38 páginasAA

    Cese del nombramiento de James Le Tall Illingworth como director el 17 feb 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Charles Waldegrave Beale como director el 01 ene 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Frederick Christopher Foreman como director el 01 ene 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Shinichi Imayoshi como director el 01 ene 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Satoshi Watabe como director el 01 ene 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Tadashi Yamada como director el 29 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Oliver Lars Edwin Peterken como director el 29 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Shinichi Imayoshi como director el 29 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Philip James Calnan como director el 29 nov 2019

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HAMPDEN LEGAL PLC
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    Secretario corporativo
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro01988859
    56301100002
    JOHNSTON, Francis William
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    Director
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    Bucks
    England
    EnglandBritish252387340001
    CASEMENT, David Alexander
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    208714580001
    FELTON, Esther
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    250659420001
    FENWICK, Graham Peter
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    250656700001
    FOREMAN, Frederick Christopher
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    257855140001
    PENDER, Charles Christopher Tresilian
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Secretario
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    British63509920002
    PURVIS, Martin Terence Alan
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helens
    England
    Secretario
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helens
    England
    British160188970001
    STEVENS, Mark Philip David
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secretario
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    British165810220001
    WALSH, Gerard Charles Paul Radford
    Stones
    Fittleworth Road Wisborough Green
    RH14 0HB Billingshurst
    West Sussex
    Secretario
    Stones
    Fittleworth Road Wisborough Green
    RH14 0HB Billingshurst
    West Sussex
    British49851890001
    FRIENDS IVORY & SIME PLC
    80 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secretario corporativo
    80 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    597700003
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secretario designado corporativo
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secretario designado corporativo
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    ADAM, Robin John Leaver
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritish185607020001
    ALBERS, Martin
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    SwitzerlandSwiss238103990001
    ANDREWS, John Michael Geoffrey
    80 Palace Gardens Terrace
    W8 4RS London
    Director
    80 Palace Gardens Terrace
    W8 4RS London
    United KingdomBritish4263690001
    ARNOLD, Simon Rory
    Bulls Barn
    Ditchling Common, Ditchling
    BN6 8TN Hassocks
    West Sussex
    Director
    Bulls Barn
    Ditchling Common, Ditchling
    BN6 8TN Hassocks
    West Sussex
    British66604710003
    BEALE, Simon Charles Waldegrave
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritish73686760003
    BOSSE, Christine
    Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's 1
    Director
    Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's 1
    DenmarkDanish134998700001
    BUCHANAN, Nigel James Cubitt
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Director
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    EnglandBritish43563090001
    CALNAN, Philip James
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish204253780001
    CARPENTER, Brian Douglas
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Director
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    EnglandBritish21299200002
    CHAKRAVERTY, Julie
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritish114083240001
    COLLINS, Alan Stanley, Sir
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's
    England
    Director
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    St Helen's
    England
    EnglandBritish164621880001
    DAVEY, Richard Harding
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish109835600002
    FEINSTEIN, Martin Douglas
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    UsaAmerican126648610001
    FOREMAN, Frederick Christopher
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish265658530001
    FUKUHARA, Kenichi
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    United KingdomJapanese174804060001
    HARRIES, David Nicholas
    39 Holden Way
    RM14 1BT Upminster
    Essex
    Director
    39 Holden Way
    RM14 1BT Upminster
    Essex
    EnglandEnglish11628540002
    HEXTALL, Richard Anthony
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritish283405430001
    HOBROW, Anthony Gordon Piers
    Park Farm Barn Maresfield
    TN22 2EE Uckfield
    East Sussex
    Director
    Park Farm Barn Maresfield
    TN22 2EE Uckfield
    East Sussex
    British6515440002
    HOLT, Anthony Wareham
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    Director
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3A 8ND London
    British29462730003
    HOLT, Anthony Wareham
    Great Orchard
    Bignor
    RH20 1PQ Pulborough
    West Sussex
    Director
    Great Orchard
    Bignor
    RH20 1PQ Pulborough
    West Sussex
    British29462730003
    ILLINGWORTH, James Le Tall
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Director
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AG London
    The Leadenhall Building
    United Kingdom
    EnglandBritish51360900002
    ILLINGWORTH, James Le Tall
    9 Ennismore Avenue
    Chiswick
    W4 1SE London
    Director
    9 Ennismore Avenue
    Chiswick
    W4 1SE London
    British51360900001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de OLD COMPANY 20 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    England
    01 oct 2020
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01085256
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Ms&Ad Insurance Group Holdings, Inc.
    Shinkawa 2-Chome
    Chuo-Ku
    1040033 Tokyo
    27-2
    Japan
    06 abr 2016
    Shinkawa 2-Chome
    Chuo-Ku
    1040033 Tokyo
    27-2
    Japan
    Forma jurídicaPublic Company
    País de registroJapan
    Autoridad legalJapan
    Lugar de registroJapan
    Número de registro010001116542
    Naturaleza del control
    • La persona tiene derecho a ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una sociedad civil que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa sociedad civil (en esa calidad) poseen, directamente o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) poseen, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene OLD COMPANY 20 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over account
    Creado el 02 ago 2011
    Entregado el 05 ago 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies up to a maximum amount of £28,000,000 due or to become due from amlin corporate services limited to the scheme on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first floating charge the account. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Lsf Pensions Management Limited
    Transacciones
    • 05 ago 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 24 ago 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 22 nov 2005
    Entregado el 30 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 30 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 24 nov 2004
    Entregado el 02 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 02 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 03 sept 2003
    Entregado el 11 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Right title and interest in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, the uncalled capital, the investments, all monetary claims and all related rights.right title and interest in and to the proceeds of any insurance policy and all related rights. By way of first floating charge the whole of the companys undertaking and assets present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC, as Agent and Trustee for the Finance Parties Under the Facility Agreement
    Transacciones
    • 11 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A debenture
    Creado el 01 ene 2003
    Entregado el 02 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The right title and interest from time to time in and to the real property. The tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, uncalled capital, the investments, the shares, all dividends interest and other monies, all monetary claims.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Trustee for the Finance Parties Under the Facility Agreement)
    Transacciones
    • 02 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 12 jul 2001
    Entregado el 14 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 nov 2000
    Entregado el 28 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (all as defined therein)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC ("Trustee")
    Transacciones
    • 28 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of further charge
    Creado el 01 ene 1998
    Entregado el 22 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a deed of covenant of even date and this charge
    Breve descripción
    Further fixed charge all right title and interest in the "mortgaged securities" and the "charged cash" as defined on the 395 and further floating charge the whole of the rights and. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society of Lloyd's
    Transacciones
    • 22 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 06 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee amending a fixed and floating charge dated 30TH november 1993 as defined in this deed
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society
    Transacciones
    • 06 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 06 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 06 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 06 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 06 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 06 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 06 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 06 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations by the company as underwriting member of lloyds and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All future profits of the underwriting business of the company at lloyds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the companys right title and interest in the mortgaged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The "Society"
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations of aut (no 10) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations of aut (no 9) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations of aut (no 8) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All future profits and moneys of the company...........see form 395.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations of aut (no 7) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations of aut (no.6) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations aut (no 5) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All moneys or other property after the date of trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations of aut (no 4) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed
    Creado el 30 nov 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations aut (no 3) limited as underwriting members of lloyds to the chargees and other obligations as specified in the trust deed
    Breve descripción
    All moneys or other property after the date of the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society,the Trustees and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0