ALCATEL-LUCENT UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ALCATEL-LUCENT UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02855052 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ALCATEL-LUCENT UK LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ALCATEL-LUCENT UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALCATEL-LUCENT UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ALCATEL UK LIMITED | 23 mar 1999 | 23 mar 1999 |
| ALCATEL LIMITED | 31 dic 1996 | 31 dic 1996 |
| ALCATEL SUBMARINE SYSTEMS U.K. LIMITED | 11 abr 1994 | 11 abr 1994 |
| SUBMITREVISE PROJECTS LIMITED | 20 sept 1993 | 20 sept 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ALCATEL-LUCENT UK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALCATEL-LUCENT UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 abr 2022 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 abr 2021 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Cormac Vincent Whelan como director el 31 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 More London Place London SE1 2AF a 1 More London Place London SE1 2AF el 03 jul 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 740 Waterside Drive, Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF a 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol BS32 4UF | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 740 Waterside Drive, Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF | 3 páginas | AD03 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 740 Waterside Drive, Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 740 Waterside Drive, Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de , 740 Waterside Drive, Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4UF, England a 1 More London Place London SE1 2AF el 28 may 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Scott Ashley Wallberg como director el 05 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ioli Tassopoulou como director el 05 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Nokia Oyj en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 oct 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Nokia Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 oct 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Cormac Vincent Whelan como director el 20 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2018 au 30 jun 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Trevor Dryden Foster como director el 20 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Ioli Tassopoulou como director el 20 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Arto Harri Tapani Sirvio como director el 20 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ingrid Pickett como director el 20 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ALCATEL-LUCENT UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSTER, Trevor Dryden | Director | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | 219680750001 | |||||
| WALLBERG, Scott Ashley | Director | 3 Sheldon Square W2 6PY London Nokia England | England | British | 266584090001 | |||||
| COUZENS, Martin Alan | Secretario | 28 Stonards Hill CM16 4QF Epping Essex | British | 27005200002 | ||||||
| JOBLING, Nicholas Andrew | Secretario | 31 Westhall Road CR6 9BJ Warlingham Surrey | British | 70386500001 | ||||||
| MARTIN, Stanley Lawrence | Secretario | 73 Hazel Road Mytchett GU16 6BA Camberley Surrey | British | 878870001 | ||||||
| MATTHEWS, Charles Howard | Secretario | Woodhouse Idsworth PO8 0AN Waterlooville Hampshire | British | 48130040001 | ||||||
| MATTHEWS, Charles Howard | Secretario | Woodhouse Idsworth PO8 0AN Waterlooville Hampshire | British | 48130040001 | ||||||
| MUIR, Donald Weir | Secretario | 3a Westholme Orpington BR6 0AN Kent | British | 109407620001 | ||||||
| NAYLOR, David Ross | Secretario | Flat 2 64 Compayne Gardens South Hampstead NW6 3RY London | British | 65465250001 | ||||||
| SADIQ, Liaqat Ali | Secretario | 22 Shortwood Avenue TW18 4JL Staines Middlesex | British | 68493890001 | ||||||
| BLAKELAW SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Harbour Court Compass Road North Harbour PO6 4ST Portsmouth Hampshire | 38915800008 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| AHMED, Tahir | Director | Waterside Drive, Aztec West Almondsbury BS32 4UF Bristol 740 England | Wales | British | 103290510002 | |||||
| AHMED, Tahir | Director | 47 Blackberry Way Pont Prennau CF23 8FE Cardiff | Wales | British | 103290510002 | |||||
| ANDERSON, Julie Anne | Director | Candwr Lane Ponthir NP18 1HW Newport Dogan Heights Monmouthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 150133040002 | |||||
| BORIS, Claude | Director | 60 Rue De Chezy 92200 Nevilly Sur Seine France | French | 36760020001 | ||||||
| CITTI, Laurent | Director | 1 Rue D'Auvergne Ramoulu 45300 Pithivers France | French | 51953760001 | ||||||
| CLARK, Patrick Thomas | Director | Bell Lane Minchinhampton GL6 9BP Stroud Church House Gloucestershire England | England | British | 268535480001 | |||||
| COUZENS, Martin Alan | Director | 28 Stonards Hill CM16 4QF Epping Essex | British | 27005200002 | ||||||
| CROSS, Derek | Director | The Thatched Cottage Handley CH3 9DT Chester | British | 40156850001 | ||||||
| DE WILDE, Julien | Director | Jabekestraat 49 9230 Wetteren Belgium | Belgian | 115665850001 | ||||||
| ENGLISH, William Stengler | Director | 8 Thurlow Road NW3 5PJ London | British | 75652880001 | ||||||
| GRIMES, Kristian Edward | Director | Waterside Drive, Aztec West Almondsbury BS32 4UF Bristol 740 England | United Kingdom | British | 152289680001 | |||||
| GRIMES, Kristian Edward | Director | Highgrove Ystradowen CF71 7TE Cowbridge 2 South Glamorgan Wales | United Kingdom | British | 152289680001 | |||||
| HORNE, Nigel, Dr | Director | Whitefriars Hosey Hill TN16 1TA Westerham Kent | British | 51059210001 | ||||||
| KERSS, William | Director | Veddw Farm MP6 6PH Devauden Gwent | British | 41046670001 | ||||||
| LECLERCQ, Jacques Bernard | Director | 7 Avenue D'Eylau Paris 75016 FOREIGN France | French | 44537280001 | ||||||
| LEWIS, David Andrew | Director | 17 Mill Road CF14 0XA Cardiff | United Kingdom | British | 63310660001 | |||||
| LORIA, Giovanni | Director | Gorse Hill Road GU25 4AU Virginia Water Charnwood Surrey England | England | British | 134764880002 | |||||
| MATTHEWS, Charles Howard | Director | 6 North Pallant PO19 1TJ Chichester West Sussex | British | 48130040002 | ||||||
| MINSHULL, Edward Peter | Director | Ways Farm Gidley Way, Horspath OX33 1TE Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 71826470002 | |||||
| NAYLOR, David Ross | Director | Flat 2 64 Compayne Gardens South Hampstead NW6 3RY London | British | 65465250001 | ||||||
| PICKETT, Ingrid | Director | Waterside Drive, Aztec West Almondsbury BS32 4UF Bristol 740 England | England | British | 245284220001 | |||||
| POLLE, Raymond | Director | Meirendreef 3 FOREIGN 2280 Grobbendonk Belgium | Belgian | 13220750001 | ||||||
| RADLEY, Peter | Director | Christys Albury End Albury SG11 2HS Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | 39293080001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ALCATEL-LUCENT UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Oyj | 02 oct 2017 | Fi-00045 Nokia Group Espoo P.O.Box 226 Finland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Nokia Uk Limited | 06 abr 2016 | Waterside Drive, Aztec West Almondsbury BS32 4UF Bristol 740 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ALCATEL-LUCENT UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 16 ago 2013 Entregado el 20 ago 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A pledge and security agreement executed outside the united kingdom over property situated there | Creado el 30 ene 2013 Entregado el 08 feb 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Intellectual property and intellectual property licenses; pledged equity interests and pledged debt; all collateral records, collateral support and supporting obligations; all proceeds, products, accesions rents and profits see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A security agreement | Creado el 30 ene 2013 Entregado el 08 feb 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción First fixed charge all the investments shares and all corresponding related rights see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene ALCATEL-LUCENT UK LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0