NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED

NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNORWICH AERO PRODUCTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02858312
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED?

    • (3210) /

    ¿Dónde se encuentra NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WESTON GROUP LIMITED17 jul 200017 jul 2000
    NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED16 sept 199916 sept 1999
    WESTON AEROSPACE LIMITED15 nov 199315 nov 1993
    LOTUSFLAME LIMITED30 sept 199330 sept 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 oct 2010

    Estado de capital el 06 oct 2010

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Cambio de datos del director Richard Bradley Lawrence el 30 sept 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mitre Secretaries Limited el 30 sept 2010

    2 páginasCH04

    Cambio de datos del director Robert David George el 17 sept 2010

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Albert Scott Yost como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert Cremin como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    4 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    4 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    4 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2005

    4 páginasAA

    legacy

    8 páginas363s

    legacy

    8 páginas363s

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2004

    4 páginasAA

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2003

    4 páginasAA

    legacy

    1 páginas244

    legacy

    8 páginas363s

    legacy

    páginas363(288)

    ¿Quiénes son los directivos de NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House, 160
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House, 160
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1447749
    38565160001
    GEORGE, Robert David
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Director
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    United StatesAmerican133332220004
    LAWRENCE, Richard Bradley
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Director
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    United StatesAnmerican122574630001
    YOST, Albert Scott
    N. Murray Lane
    99019 Liberty Lake
    1225
    Washington
    Usa
    Director
    N. Murray Lane
    99019 Liberty Lake
    1225
    Washington
    Usa
    United StatesAmerican149468560001
    ANDREWS, John Beresford
    Lynbere Apple Grove Ashfield Road
    Wetherden
    IP14 3LY Stowmarket
    Suffolk
    Secretario
    Lynbere Apple Grove Ashfield Road
    Wetherden
    IP14 3LY Stowmarket
    Suffolk
    British8066550002
    BUCKLEY, Cathryn Ann
    38 Calder Close
    WR9 8DU Droitwich
    Worcestershire
    Secretario
    38 Calder Close
    WR9 8DU Droitwich
    Worcestershire
    British64030380001
    HOWARD, Robert Damian
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    Secretario
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    British43509060001
    CREMIN, Robert William
    9226 South East 33rd Place
    Mercer Island
    Washington 98040
    Usa
    Director
    9226 South East 33rd Place
    Mercer Island
    Washington 98040
    Usa
    UsaAmerican67768140003
    HETHERINGTON, Neil
    Gate Lodge Ellanore Lane
    West Wittering
    PO20 8AN Chichester
    West Sussex
    Director
    Gate Lodge Ellanore Lane
    West Wittering
    PO20 8AN Chichester
    West Sussex
    British36206310001
    HOWARD, Robert Damian
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    Director
    Ashfield Blacknest
    GU34 4PZ Alton
    Hampshire
    British43509060001
    KRING, Larry Albert
    3265 126th Ave Ne
    Bellevue
    Washington
    Wa 98005
    Director
    3265 126th Ave Ne
    Bellevue
    Washington
    Wa 98005
    American108012180001
    RICKETTS, Andrew Frederick
    St Andrews Lodge Church Lane
    West Deeping
    PE6 9HU Peterborough
    Lincolnshire
    Director
    St Andrews Lodge Church Lane
    West Deeping
    PE6 9HU Peterborough
    Lincolnshire
    British8066560004
    TEE, Henry Leonard
    Vineyard Manor High Street
    SG10 6BS Much Hadham
    Hertfordshire
    Director
    Vineyard Manor High Street
    SG10 6BS Much Hadham
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10786060002
    TEMPEST, Philip Anthony
    Field House
    Kirton
    IP10 0PZ Ipswich
    Suffolk
    Director
    Field House
    Kirton
    IP10 0PZ Ipswich
    Suffolk
    British36898820002
    VAISEY, Alfred John
    Royse House 4 Royse Grove
    SG8 9EP Royston
    Hertfordshire
    Director
    Royse House 4 Royse Grove
    SG8 9EP Royston
    Hertfordshire
    British22038910002
    WOOD, Richard John
    10217 Se 21st Street
    Bellevue
    Washington 98004
    Usa
    Director
    10217 Se 21st Street
    Bellevue
    Washington 98004
    Usa
    British110561630001

    ¿Tiene NORWICH AERO PRODUCTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over goodwill
    Creado el 24 nov 1993
    Entregado el 07 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or weston aerospace (1994) limited to the chargee under the terms of the facilities agreement and/orthe swap agreements (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustees
    Transacciones
    • 07 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 26 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of patents
    Creado el 24 nov 1993
    Entregado el 07 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or weston aerospace (1994) limited to the chargee under the terms of the facilities agreement and/orthe swap agreements (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee
    Transacciones
    • 07 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 26 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 24 nov 1993
    Entregado el 07 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facility agreement and/or the swap agreements (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transacciones
    • 07 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 26 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0