HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED

HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02864153
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Towergate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN a 92 London Street Reading Berkshire RG1 4SJ el 19 may 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 05 may 2015

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Mark Steven Hodges como director el 17 oct 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 oct 2014

    Estado de capital el 02 oct 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Nombramiento de Jennifer Owens como secretario

    1 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 oct 2013

    Estado de capital el 11 oct 2013

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Samuel Clark como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Peter Cullum como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    5 páginasAA

    Nombramiento de Mr Mark Steven Hodges como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy Philip como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Scott Egan como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Scott Egan como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Samuel Thomas Budgen Clark como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Andrew Hunter como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    5 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Stewart Hunter como secretario

    1 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OWENS, Jennifer
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Secretario
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    183297560001
    EGAN, Scott
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Director
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    EnglandBritish170703910001
    ALEXANDER, Peter
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    Secretario
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    British60245740001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    153023140001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    161872300001
    CRATON, Timothy Charles
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    British76055420004
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Secretario
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    British99424380001
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    156617460001
    LYONS, Derek George William
    30 Downleaze
    South Woodham Ferrers
    CM3 5SN Chelmsford
    Essex
    Secretario
    30 Downleaze
    South Woodham Ferrers
    CM3 5SN Chelmsford
    Essex
    Irish20310970001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Secretario
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    British6180280001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    CROCKER, Nicholas John David
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    Director
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    British60697560014
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Director
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    United KingdomBritish140488120001
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Director
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    EnglandBritish99424380001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Director
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United KingdomBritish58444370003
    LYONS, Derek George William
    30 Downleaze
    South Woodham Ferrers
    CM3 5SN Chelmsford
    Essex
    Director
    30 Downleaze
    South Woodham Ferrers
    CM3 5SN Chelmsford
    Essex
    EnglandIrish20310970001
    PHILIP, Timothy Duncan
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Director
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    EnglandAustralian99066410002
    PROVERBS, Antony
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Director
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    EnglandBritish79185700013
    SHARP, Brian Stephen
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    Director
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    British18202060001
    SHARP, Jean Marie
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    Director
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    British18202050001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    ¿Tiene HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 31 ago 2001
    Entregado el 13 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (the agent), the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank, the hedging bank, the zero per cent lenders, the investors and to any of them on any account whatsoever including without limitation under any of the financing documents (all terms as defined)
    Breve descripción
    (Other than f/h property k/a 317 woodham lane new haw t/no.SY350608 and the f/h land at the south west of scotland bridge road new haw t/no.SY536467 in each case so long as the same is charged by towergate chase parkinson limited to coutts & co). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 31 mar 2000
    Entregado el 07 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender, the Mezzanine Lender, the Overdraft Bank, the Hedging Bank and the Investor (All as Defined)
    Transacciones
    • 07 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene HOMECARE UNDERWRITING AGENCY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 may 2015Inicio de la liquidación
    24 nov 2015Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David William Tann
    Wilkins Kennedy Llp
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Profesional
    Wilkins Kennedy Llp
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Matthew John Waghorn
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Profesional
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0