TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02866179 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ACDTRIDON EUROPE LIMITED | 29 may 1996 | 29 may 1996 |
| AUTOMOTIVE COMPONENTS DUNSTABLE LIMITED | 14 dic 1993 | 14 dic 1993 |
| PIRGOS LIMITED | 26 oct 1993 | 26 oct 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 8 páginas | 4.71 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Coral Suzanne Bidel como director el 22 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel Marc Richard Jaffe como director el 09 jul 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU a Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY el 12 dic 2014 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||||||
Resolución de insolvencia Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie" | 1 páginas | LIQ MISC RES | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 10 oct 2014
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 12 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Nicolas Paul Wilkinson como director el 30 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas C. Reeve como director el 30 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Honor Lewzey como director el 30 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Miss Coral Bidel el 05 sept 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Marc Richard Jaffe como director el 13 ago 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Intertrust (Uk) Limited como secretario el 13 ago 2014 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||||||
Nombramiento de Miss Coral Bidel como director el 13 ago 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Honor Lewzey como secretario el 13 ago 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE a 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU el 22 ago 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERTRUST (UK) LIMITED | Secretario corporativo | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry United Kingdom |
| 188126550001 | ||||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Secretario | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570004 | ||||||||||
| HOPSTER, Michael John | Secretario | 40 Brooksbys Walk E9 6DF London Flat B United Kingdom | 157101930001 | |||||||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Secretario | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | 165833360001 | |||||||||||
| SHORTT, Eugene | Secretario | 50 Green Drift SG8 5BX Royston Hertfordshire | British | 4764420001 | ||||||||||
| YEOMANS, Alan Richard | Secretario | 16 Long Massey MK46 5NR Olney Buckinghamshire | British | 26276020001 | ||||||||||
| CMH SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000940001 | |||||||||||
| ABBOTT, Brian Arthur | Director | 18 Alma Farm Road Toddington LU5 6BG Dunstable Bedfordshire | England | British | 38296100001 | |||||||||
| BIDEL, Coral Suzanne | Director | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United Kingdom | British | 179297460002 | |||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Director | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 47432570004 | |||||||||
| CAREY, Stephen James | Director | 145 High Street Harrold MK43 7ED Bedford Bedfordshire | British | 76189900002 | ||||||||||
| CORPATAUX, Beat Eugene | Director | Marly Strasse 3 CH 17 34 Tentlingen Switzerland | Switzerland | Swiss | 49248640001 | |||||||||
| DRUMMOND, David Fraser | Director | 3 St Anthony's Close RG12 2EB Bracknell Berkshire | British | 43960000001 | ||||||||||
| FLANAGAN, Paul Edward | Director | Flat 9 19 Holland Park W11 3TD London | United Kingdom | British | 69281780002 | |||||||||
| HILLSON, Anthony Leonard | Director | 18 Tavistock Avenue Ampthill MK45 2RY Bedford | British | 43960090001 | ||||||||||
| HOFMANN, Helmut | Director | 12 Meadow Height Crt L4J 1V6 Thornhill Ontario Canada | Canadian | 46601750001 | ||||||||||
| HOPSTER, Michael John | Director | Flat B 40 Brooksbys Walk E9 6DF London | United Kingdom | British | 77921850004 | |||||||||
| HOTTINGER, Michael | Director | 5000 Country Club Drive 37027 Brentwood Tennessee Usa | American | 46550450001 | ||||||||||
| JAFFE, Daniel Marc Richard | Director | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United Kingdom | British | 140811810001 | |||||||||
| KEECH, Craig William | Director | 174 Slad Road GL5 1RJ Stroud Gloucestershire | British | 45367870003 | ||||||||||
| KEECH, Dennis | Director | 216 Old Bedford Road LU2 7HP Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | 24425650001 | |||||||||
| KEECH, Matthew David | Director | 36 Statham Close LU3 4EJ Luton Bedfordshire | British | 38296150001 | ||||||||||
| KINGSBURGH, Murray | Director | 31 Warlock Crescent MKU 2H8 Willowdale Ontario Canada | Canadian | 46550570001 | ||||||||||
| LANGSHAW, Ralph | Director | Westway 71a West Common AL5 2LD Harpenden Hertfordshire | British | 37169710001 | ||||||||||
| LANGSHAW, Ralph | Director | Westway 71a West Common AL5 2LD Harpenden Hertfordshire | British | 37169710001 | ||||||||||
| LEE, Norman Holt | Director | 9 Compgate Eaton Bray LU6 2AU Dunstable Bedfordshire | British | 38296170001 | ||||||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Director | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 59381700003 | |||||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Director | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||||||
| MUSHTAQ, Mohammed Arif | Director | 13 Edkins Close Bushmead LU2 7SS Luton Bedfordshire | British | 42865020001 | ||||||||||
| PORTER, Norman Charles | Director | Farnham House 2 Beedingwood Drive Forest Road Colgate RH12 4TE Horsham West Sussex | England | British | 445360034 | |||||||||
| REEVE, Thomas C. | Director | Wewatta Street 80202 Denver 1551 Colorado Usa | United States | American | 161822390001 | |||||||||
| RENNER, James | Director | 3453 Sawmill Valley Drive LSL 3A3 Mississauga Ontario Canada | Canadian | 46550730001 | ||||||||||
| WILKINSON, Nicolas Paul | Director | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 48808690001 | |||||||||
| YEOMANS, Alan Richard | Director | 16 Long Massey MK46 5NR Olney Buckinghamshire | British | 26276020001 | ||||||||||
| CMH DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000930001 |
¿Tiene TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Creado el 30 sept 2010 Entregado el 15 oct 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security agreement | Creado el 30 sept 2010 Entregado el 13 oct 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of composite guarantee and debenture | Creado el 08 feb 1996 Entregado el 23 feb 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from tridon limited,the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the deed | |
Breve descripción All right title estate and other interests of the chargor in or over a lease dated 29TH january 1996 of land and buildings situate on the south west of high street north dunstable bedfordshire and all plant and machinery and all assets charged and assigned as outlined on the form 395 and attached schedules please see form for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 08 feb 1994 Entregado el 16 feb 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The assigns the goodwill of the business to the bank the benefit of any licences all intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage and specific charge | Creado el 08 feb 1994 Entregado el 16 feb 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All and every interest in or over a lease dated 4/2/94 of land and buildings on the south west of high street north dunstable bedfordshire and situate and k/a the waterloo sports ground high street north dunstable bedfordshire t/no'SBD95171 and BD26409 all rights under an option agreement dated 4/2/94. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0