TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED

TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02866179
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ACDTRIDON EUROPE LIMITED29 may 199629 may 1996
    AUTOMOTIVE COMPONENTS DUNSTABLE LIMITED14 dic 199314 dic 1993
    PIRGOS LIMITED26 oct 199326 oct 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Cese del nombramiento de Coral Suzanne Bidel como director el 22 oct 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Daniel Marc Richard Jaffe como director el 09 jul 2015

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU a Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY el 12 dic 2014

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resolución de insolvencia

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 páginasLIQ MISC RES

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 26 nov 2014

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 dic 2014

    Estado de capital el 09 dic 2014

    • Capital: GBP 22,903,734
    SH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 10 oct 2014

    • Capital: GBP 22,903,734
    3 páginasSH01

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    12 páginasAA

    Cese del nombramiento de Nicolas Paul Wilkinson como director el 30 sept 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Thomas C. Reeve como director el 30 sept 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Honor Lewzey como director el 30 sept 2014

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Miss Coral Bidel el 05 sept 2014

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Daniel Marc Richard Jaffe como director el 13 ago 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Intertrust (Uk) Limited como secretario el 13 ago 2014

    2 páginasAP04

    Nombramiento de Miss Coral Bidel como director el 13 ago 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Honor Lewzey como secretario el 13 ago 2014

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE a 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU el 22 ago 2014

    1 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 dic 2013

    Estado de capital el 10 dic 2013

    • Capital: GBP 18,010,000
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06307550
    188126550001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570004
    HOPSTER, Michael John
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    Secretario
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    157101930001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Secretario
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    165833360001
    SHORTT, Eugene
    50 Green Drift
    SG8 5BX Royston
    Hertfordshire
    Secretario
    50 Green Drift
    SG8 5BX Royston
    Hertfordshire
    British4764420001
    YEOMANS, Alan Richard
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    Secretario
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    British26276020001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario designado corporativo
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    ABBOTT, Brian Arthur
    18 Alma Farm Road
    Toddington
    LU5 6BG Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    18 Alma Farm Road
    Toddington
    LU5 6BG Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish38296100001
    BIDEL, Coral Suzanne
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Director
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish179297460002
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish47432570004
    CAREY, Stephen James
    145 High Street
    Harrold
    MK43 7ED Bedford
    Bedfordshire
    Director
    145 High Street
    Harrold
    MK43 7ED Bedford
    Bedfordshire
    British76189900002
    CORPATAUX, Beat Eugene
    Marly Strasse 3
    CH 17 34 Tentlingen
    Switzerland
    Director
    Marly Strasse 3
    CH 17 34 Tentlingen
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss49248640001
    DRUMMOND, David Fraser
    3 St Anthony's Close
    RG12 2EB Bracknell
    Berkshire
    Director
    3 St Anthony's Close
    RG12 2EB Bracknell
    Berkshire
    British43960000001
    FLANAGAN, Paul Edward
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    Director
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    United KingdomBritish69281780002
    HILLSON, Anthony Leonard
    18 Tavistock Avenue
    Ampthill
    MK45 2RY Bedford
    Director
    18 Tavistock Avenue
    Ampthill
    MK45 2RY Bedford
    British43960090001
    HOFMANN, Helmut
    12
    Meadow Height Crt
    L4J 1V6 Thornhill
    Ontario
    Canada
    Director
    12
    Meadow Height Crt
    L4J 1V6 Thornhill
    Ontario
    Canada
    Canadian46601750001
    HOPSTER, Michael John
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Director
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    United KingdomBritish77921850004
    HOTTINGER, Michael
    5000 Country Club Drive
    37027 Brentwood
    Tennessee
    Usa
    Director
    5000 Country Club Drive
    37027 Brentwood
    Tennessee
    Usa
    American46550450001
    JAFFE, Daniel Marc Richard
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Director
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish140811810001
    KEECH, Craig William
    174 Slad Road
    GL5 1RJ Stroud
    Gloucestershire
    Director
    174 Slad Road
    GL5 1RJ Stroud
    Gloucestershire
    British45367870003
    KEECH, Dennis
    216 Old Bedford Road
    LU2 7HP Luton
    Bedfordshire
    Director
    216 Old Bedford Road
    LU2 7HP Luton
    Bedfordshire
    United KingdomBritish24425650001
    KEECH, Matthew David
    36 Statham Close
    LU3 4EJ Luton
    Bedfordshire
    Director
    36 Statham Close
    LU3 4EJ Luton
    Bedfordshire
    British38296150001
    KINGSBURGH, Murray
    31 Warlock Crescent
    MKU 2H8 Willowdale
    Ontario
    Canada
    Director
    31 Warlock Crescent
    MKU 2H8 Willowdale
    Ontario
    Canada
    Canadian46550570001
    LANGSHAW, Ralph
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    British37169710001
    LANGSHAW, Ralph
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Westway
    71a West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    British37169710001
    LEE, Norman Holt
    9 Compgate
    Eaton Bray
    LU6 2AU Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    9 Compgate
    Eaton Bray
    LU6 2AU Dunstable
    Bedfordshire
    British38296170001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Director
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish59381700003
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MUSHTAQ, Mohammed Arif
    13 Edkins Close
    Bushmead
    LU2 7SS Luton
    Bedfordshire
    Director
    13 Edkins Close
    Bushmead
    LU2 7SS Luton
    Bedfordshire
    British42865020001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Director
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    REEVE, Thomas C.
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    Director
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    United StatesAmerican161822390001
    RENNER, James
    3453 Sawmill Valley Drive
    LSL 3A3 Mississauga
    Ontario
    Canada
    Director
    3453 Sawmill Valley Drive
    LSL 3A3 Mississauga
    Ontario
    Canada
    Canadian46550730001
    WILKINSON, Nicolas Paul
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Director
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish48808690001
    YEOMANS, Alan Richard
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    Director
    16 Long Massey
    MK46 5NR Olney
    Buckinghamshire
    British26276020001
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Director designado corporativo
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001

    ¿Tiene TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A security agreement
    Creado el 30 sept 2010
    Entregado el 15 oct 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust Fsb (The Collateral Agent)
    Transacciones
    • 15 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 03 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 30 sept 2010
    Entregado el 13 oct 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Citicorp Usa, Inc. (The Collateral Agent)
    Transacciones
    • 13 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 03 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of composite guarantee and debenture
    Creado el 08 feb 1996
    Entregado el 23 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from tridon limited,the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the deed
    Breve descripción
    All right title estate and other interests of the chargor in or over a lease dated 29TH january 1996 of land and buildings situate on the south west of high street north dunstable bedfordshire and all plant and machinery and all assets charged and assigned as outlined on the form 395 and attached schedules please see form for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 23 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 08 feb 1994
    Entregado el 16 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The assigns the goodwill of the business to the bank the benefit of any licences all intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 09 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage and specific charge
    Creado el 08 feb 1994
    Entregado el 16 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and every interest in or over a lease dated 4/2/94 of land and buildings on the south west of high street north dunstable bedfordshire and situate and k/a the waterloo sports ground high street north dunstable bedfordshire t/no'SBD95171 and BD26409 all rights under an option agreement dated 4/2/94. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 nov 2014Inicio de la liquidación
    23 feb 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Profesional
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0