MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02866278 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED?
- Agencias de publicidad (73110) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Sea Containers 18 Upper Ground SE1 9ET London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MEDIAEDGE:CIA UK LIMITED | 20 mar 2002 | 20 mar 2002 |
| CIA UK LIMITED | 25 ago 2000 | 25 ago 2000 |
| CIA MEDIANETWORK UK LIMITED | 23 ene 1995 | 23 ene 1995 |
| CIA MEDIANETWORK LIMITED | 12 jul 1994 | 12 jul 1994 |
| CIA MEDIA LIMITED | 21 oct 1993 | 21 oct 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cese del nombramiento de Paul Hutchison como director el 22 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 10 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 oct 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 19 páginas | AA | ||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Cese del nombramiento de Jason Gary Dormieux como director el 15 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Sandeep Vohra como secretario el 28 sept 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Shil Patel como director el 27 sept 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Thomas George como director el 28 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Sandeep Vohra como director el 28 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 oct 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 19 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Sarah Louise Hennessy como director el 28 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 oct 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Sandeep Vohra como director el 01 abr 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Thomas George como secretario el 01 abr 2016 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Sandeep Vohra como secretario el 01 abr 2016 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Stuart Bowden como director el 01 abr 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Drew Englebright como director el 31 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATEL, Shil | Director | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | England | British | 240793760001 | |||||
| BRYAN, David John | Secretario | 27 Greenholm Road Eltham SE9 1UQ London | British | 111587140001 | ||||||
| CARPENTER, Gillian Marie | Secretario | 23 Sedgwick Road Leyton E10 6QR London | British | 18058600001 | ||||||
| GEORGE, Thomas | Secretario | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | 185705720001 | |||||||
| HATCH, Steven Thomas | Secretario | 1 Paris Garden London SE1 8NU | 158792100001 | |||||||
| PAGE, Elizabeth | Secretario | 37 Swallow Rise Knaphill GU21 2LH Woking Surrey | British | 53767920001 | ||||||
| RUCK, Clare Elizabeth | Secretario | 45 Thorparch Road SW8 4SX London | British | 69581210002 | ||||||
| SEDDON, Nigel Francis | Secretario | 100 A Gowan Avenue Fulham SW6 6RG London | British | 125258330001 | ||||||
| STANFORD, Nigel John | Secretario | 103 Noel Road N1 8HD London | British | 80146530001 | ||||||
| VOHRA, Sandeep | Secretario | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | 206762310001 | |||||||
| ALMEIDA, Jacqueline Ann | Director | Gloucester House 25 Lyons Crescent TN9 1EY Tonbridge Kent | British | 66410570001 | ||||||
| ANDERS, Ian | Director | 44 Cranley Gardens N13 4LS London | British | 65786400001 | ||||||
| ANDERSON, Michael Graham | Director | 29 Seymour Road Wimbledon SW19 5JL London | British | 74402160003 | ||||||
| AUSTIN, Mark | Director | 25 Melville Road SW13 9RH Barnes | British | 110371650001 | ||||||
| BLATCHFORD, Robert | Director | Higher Pound Farm Monkton Wyld DT6 6DD Bridport Dorset | British | 42769850002 | ||||||
| BOLDEN, Andrew Richard | Director | 12 Rosebank Avenue HA0 2TW Wembley Middlesex | British | 27291750003 | ||||||
| BOWDEN, Stuart | Director | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | England | British | 168631720001 | |||||
| BRITTON, Richard Arthur | Director | Upper Maisonette 46 Alderney Street SW1V 4EX London | British | 65359400002 | ||||||
| BRYAN, David John | Director | 27 Greenholm Road Eltham SE9 1UQ London | England | British | 111587140001 | |||||
| BRYDON, Alan Robert | Director | 134 Broomwood Road SW11 6JZ London | United Kingdom | British | 85144970001 | |||||
| BURDETT, Richard Geoffrey | Director | 42 Agamemnon Road NW6 1EN London | United Kingdom | British | 61187690004 | |||||
| CHAPLAIN, Jane | Director | 3 Cooperage Court 6 Gainsford Street SE1 2NG London | British | 50635430001 | ||||||
| CLILVERD, Andrew James | Director | 42 Chipperfield Road HP3 0JW Bovingdon Hertfordshire | British | 92442050001 | ||||||
| COX, Simon Phillip | Director | 49 The Chase Thundersley SS7 3BS Benfleet Essex | United Kingdom | British | 62056270001 | |||||
| COX, Simon Phillip | Director | 49 The Chase Thundersley SS7 3BS Benfleet Essex | United Kingdom | British | 62056270001 | |||||
| DAVIES, Hamish Cledwyn | Director | 3 Lansdowne House Lansdowne Road Holland Park W11 3LP London | British | 77835090001 | ||||||
| DAVIS, Timothy | Director | The Oaks 3 Jenners Close RH7 6EQ Lingfield Surrey | England | British | 50635370002 | |||||
| DE NARDIS DI PRATA, Mainardo | Director | 111 Old Church Street SW3 6DX London | Italian | 35332610007 | ||||||
| DENEKAMP, Johan Harmanus | Director | 7 Tower Walk 7 St Katharines Dock E1W 1LP London | England | British | 98513550001 | |||||
| DEUTROM, Murray Scott | Director | 150 Hallowell Road HA6 1DU Northwood Middlesex | British | 50635500001 | ||||||
| DORMIEUX, Jason Gary | Director | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | United Kingdom | British | 185698750001 | |||||
| DOVEY, Joshua Hylton | Director | 77 Langthorne Street Fulham SW6 6JU London | British | 41806670002 | ||||||
| ELMS, Michael Robert | Director | Millfield Shaw Round Street Sole Street DA13 9BA Gravesend Kent | United Kingdom | British | 36542740002 | |||||
| ENGLEBRIGHT, Drew | Director | 18 Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers United Kingdom | United Kingdom | British | 208240460001 | |||||
| FLETCHER, David Martin | Director | 32 Shakespeare Road W7 1LR London | England | British | 109237430001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediaedge:Cia Uk Holdings | 21 oct 2016 | Upper Ground SE1 9ET London Sea Containers England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MEDIAEDGE:CIA UK INVESTMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creado el 10 abr 1997 Entregado el 30 abr 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0