THE WINE STUDIO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE WINE STUDIO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02867477 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE WINE STUDIO LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra THE WINE STUDIO LIMITED?
| Dirección de la sede social | Whitchurch Lane BS14 0JZ Bristol |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE WINE STUDIO LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SAMUEL DOW LIMITED | 10 dic 1993 | 10 dic 1993 |
| TRUSHELFCO (NO. 1962) LIMITED | 01 nov 1993 | 01 nov 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE WINE STUDIO LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 feb 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE WINE STUDIO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2021 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del secretario C&C Management Services Limited el 24 mar 2021 | 1 páginas | CH04 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2020 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2019 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Jonathan Solesbury como director el 14 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Riona Heffernan como director el 14 oct 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Andrea Pozzi como director el 14 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Exercice comptable précédent raccourci du 27 abr 2019 au 28 feb 2019 | 1 páginas | AA01 | ||
Cese del nombramiento de David George Johnston como director el 29 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2018 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de C&C Management Services Limited como secretario el 26 sept 2018 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de C&C Management Services (Uk) Limited como secretario el 26 sept 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Modification des détails de Matthew Clark (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 may 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||
Nombramiento de Mr David Johnston como director el 17 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Jonathan Solesbury como director el 17 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen Frederick Jebson como director el 17 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Riley como director el 17 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE WINE STUDIO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C&C MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Keeper Road Crumlin Bulmers House Dublin 12, D12 K702 Ireland |
| 172928540001 | ||||||||||||||
| HEFFERNAN, Riona | Director | Lane BS14 0JZ Bristol Whitchurch | Ireland | Irish | 203083000001 | |||||||||||||
| ROBERTSON, Ewan James | Director | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | Scotland | British | 208215190001 | |||||||||||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Secretario | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | 28396500005 | ||||||||||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Secretario | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | British | 69554640002 | ||||||||||||||
| PHILLIPS, David John | Secretario | BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane United Kingdom | 158113210001 | |||||||||||||||
| C&C MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3LH Exeter Ashford House England |
| 245149380001 | ||||||||||||||
| TRUSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | 900007200001 | |||||||||||||||
| AYLWIN, Mark Terence | Director | Lane BS14 0JZ Bristol Whitchurch | England | British | 105140040001 | |||||||||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||||||||||
| CHANDLER, Christine Anne | Director designado | 31 Chesnut Grove New Malden Surrey | British | 900007180001 | ||||||||||||||
| CHRISTENSEN, Troy | Director | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | American | 130789730003 | |||||||||||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Director | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | 28396500005 | |||||||||||||
| CREIGHTON, Thomas Hugh | Director | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | 157727790001 | |||||||||||||
| DANDO, Stephen Peter | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||||||||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Director | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||||||||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Director | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137615160001 | |||||||||||||
| GRISMAN, Martin Gerald | Director | Whitchurch Lane Whitchurch BS14 0JZ Bristol - Avon United Kingdom | England | British | 69428030002 | |||||||||||||
| HODGES, Nigel Ian | Director | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | 75692570001 | ||||||||||||||
| HUMPHREYS, Andrew | Director | Lane BS14 0JZ Bristol Whitchurch | England | British | 200489460001 | |||||||||||||
| HUNTER, Diana | Director | Lane BS14 0JZ Bristol Whitchurch | England | British | 170154190002 | |||||||||||||
| HUNTER, Diana | Director | Lane BS14 0JZ Bristol Whitchurch | England | British | 170154190002 | |||||||||||||
| JEBSON, Stephen Frederick | Director | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | England | British | 171865850001 | |||||||||||||
| JOHNSTON, David George | Director | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | Ireland | Irish | 198738340001 | |||||||||||||
| KLEIN, David | Director | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | 119928070001 | ||||||||||||||
| LOUSADA, James David | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | 152222000001 | |||||||||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Director | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 69554640002 | |||||||||||||
| MORAMARCO, Jon | Director | C8 Trinity Gate Epsom Road GU1 3PW Guildford Surrey | American | 114902210001 | ||||||||||||||
| MORAN, Mark | Director | Crewe CW1 6BP Cheshire Weston Road United Kingdom | United Kingdom | British | 60066000008 | |||||||||||||
| PETERS, Richard David | Director | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | 60630980002 | |||||||||||||
| POZZI, Andrea | Director | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | Scotland | Italian | 195181530001 | |||||||||||||
| REEVE, Robert Arthur | Director designado | 6 Wellesford Close SM7 2HL Banstead Surrey | British | 900007190001 | ||||||||||||||
| RILEY, Mark | Director | Duke Street G31 1JD Glasgow 161 Scotland | England | British | 245151070001 | |||||||||||||
| SCHAAFSMA, Paul Michael | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 105189170004 | |||||||||||||
| SMITH, Andrew Peter | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | 175517180001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE WINE STUDIO LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Clark Bibendum (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Whitchurch BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene THE WINE STUDIO LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 08 jul 2016 Entregado el 22 jul 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 08 jul 2016 Entregado el 21 jul 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 09 oct 2015 Entregado el 16 oct 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 09 oct 2015 Entregado el 15 oct 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 09 oct 2015 Entregado el 15 oct 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security agreement | Creado el 17 abr 2007 Entregado el 23 abr 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts etc, insurances, other contracts, intellectual property, goodwill and floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0