THE WINE STUDIO LIMITED

THE WINE STUDIO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE WINE STUDIO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02867477
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE WINE STUDIO LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra THE WINE STUDIO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Whitchurch
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE WINE STUDIO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SAMUEL DOW LIMITED10 dic 199310 dic 1993
    TRUSHELFCO (NO. 1962) LIMITED01 nov 199301 nov 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE WINE STUDIO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE WINE STUDIO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2021

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del secretario C&C Management Services Limited el 24 mar 2021

    1 páginasCH04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2020

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 oct 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2019

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Jonathan Solesbury como director el 14 oct 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Riona Heffernan como director el 14 oct 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrea Pozzi como director el 14 oct 2019

    1 páginasTM01

    Exercice comptable précédent raccourci du 27 abr 2019 au 28 feb 2019

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de David George Johnston como director el 29 ene 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2018

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de C&C Management Services Limited como secretario el 26 sept 2018

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de C&C Management Services (Uk) Limited como secretario el 26 sept 2018

    1 páginasTM02

    Modification des détails de Matthew Clark (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 may 2018

    2 páginasPSC05

    Nombramiento de Mr David Johnston como director el 17 abr 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Jonathan Solesbury como director el 17 abr 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Frederick Jebson como director el 17 abr 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Riley como director el 17 abr 2018

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de THE WINE STUDIO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    C&C MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Keeper Road
    Crumlin
    Bulmers House
    Dublin 12, D12 K702
    Ireland
    Secretario corporativo
    Keeper Road
    Crumlin
    Bulmers House
    Dublin 12, D12 K702
    Ireland
    Forma jurídicaPRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES - LTD
    Tipo de identificaciónOtra entidad corporativa o firma
    Autoridad legalIRISH COMPANIES ACT 2014
    Número de registro2867477
    172928540001
    HEFFERNAN, Riona
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch
    Director
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch
    IrelandIrish203083000001
    ROBERTSON, Ewan James
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    Director
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    ScotlandBritish208215190001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Secretario
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    British28396500005
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    British69554640002
    PHILLIPS, David John
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch Lane
    United Kingdom
    Secretario
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch Lane
    United Kingdom
    158113210001
    C&C MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3LH Exeter
    Ashford House
    England
    Secretario corporativo
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3LH Exeter
    Ashford House
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06743858
    245149380001
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Secretario designado corporativo
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    AYLWIN, Mark Terence
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch
    Director
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch
    EnglandBritish105140040001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    CHANDLER, Christine Anne
    31 Chesnut Grove
    New Malden
    Surrey
    Director designado
    31 Chesnut Grove
    New Malden
    Surrey
    British900007180001
    CHRISTENSEN, Troy
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAmerican130789730003
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Director
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    United KingdomBritish28396500005
    CREIGHTON, Thomas Hugh
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    Director
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    EnglandBritish157727790001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    ETHERIDGE, Hugh Charles
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Director
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    United KingdomBritish1491130002
    GLENNIE, Helen Margaret
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137615160001
    GRISMAN, Martin Gerald
    Whitchurch Lane
    Whitchurch
    BS14 0JZ Bristol
    -
    Avon
    United Kingdom
    Director
    Whitchurch Lane
    Whitchurch
    BS14 0JZ Bristol
    -
    Avon
    United Kingdom
    EnglandBritish69428030002
    HODGES, Nigel Ian
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    Director
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    British75692570001
    HUMPHREYS, Andrew
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch
    Director
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch
    EnglandBritish200489460001
    HUNTER, Diana
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch
    Director
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch
    EnglandBritish170154190002
    HUNTER, Diana
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch
    Director
    Lane
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch
    EnglandBritish170154190002
    JEBSON, Stephen Frederick
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    Director
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    EnglandBritish171865850001
    JOHNSTON, David George
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    Director
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    IrelandIrish198738340001
    KLEIN, David
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    Director
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    American119928070001
    LOUSADA, James David
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish152222000001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish69554640002
    MORAMARCO, Jon
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    Director
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    American114902210001
    MORAN, Mark
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Weston Road
    United Kingdom
    Director
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Weston Road
    United Kingdom
    United KingdomBritish60066000008
    PETERS, Richard David
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    Director
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish60630980002
    POZZI, Andrea
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    Director
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    ScotlandItalian195181530001
    REEVE, Robert Arthur
    6 Wellesford Close
    SM7 2HL Banstead
    Surrey
    Director designado
    6 Wellesford Close
    SM7 2HL Banstead
    Surrey
    British900007190001
    RILEY, Mark
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    Director
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    EnglandBritish245151070001
    SCHAAFSMA, Paul Michael
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish105189170004
    SMITH, Andrew Peter
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish175517180001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de THE WINE STUDIO LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Whitchurch
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch Lane
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Whitchurch
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch Lane
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro6133835
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene THE WINE STUDIO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 08 jul 2016
    Entregado el 22 jul 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 22 jul 2016Registro de una carga (MR01)
    • 10 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 08 jul 2016
    Entregado el 21 jul 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 21 jul 2016Registro de una carga (MR01)
    • 10 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 09 oct 2015
    Entregado el 16 oct 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 16 oct 2015Registro de una carga (MR01)
    • 10 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 09 oct 2015
    Entregado el 15 oct 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 15 oct 2015Registro de una carga (MR01)
    • 10 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 09 oct 2015
    Entregado el 15 oct 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 15 oct 2015Registro de una carga (MR01)
    • 10 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 17 abr 2007
    Entregado el 23 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts etc, insurances, other contracts, intellectual property, goodwill and floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 23 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0