BRITISH ASSOCIATION OF SETTLEMENTS AND SOCIAL ACTION CENTRES

BRITISH ASSOCIATION OF SETTLEMENTS AND SOCIAL ACTION CENTRES

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRITISH ASSOCIATION OF SETTLEMENTS AND SOCIAL ACTION CENTRES
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 02869337
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRITISH ASSOCIATION OF SETTLEMENTS AND SOCIAL ACTION CENTRES?

    • (9112) /

    ¿Dónde se encuentra BRITISH ASSOCIATION OF SETTLEMENTS AND SOCIAL ACTION CENTRES?

    Dirección de la sede social
    33 Corsham Street
    London
    N1 6DR
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITISH ASSOCIATION OF SETTLEMENTS AND SOCIAL ACTION CENTRES?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITISH ASSOCIATION OF SETTLEMENTS AND SOCIAL ACTION CENTRES?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    31 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 27 oct 2010, aucune liste de membres fournie

    19 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    31 páginasAA

    legacy

    6 páginasMG01

    Nombramiento de Professor Marilyn Elaine Taylor como director

    1 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Ruth Anne Marriott como director

    1 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 27 oct 2009, aucune liste de membres fournie

    10 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    29 páginasAA

    Cambio de datos del director Andrew John Robinson el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Joanna Susan Holmes el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Donna Alicia Liburd el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Frankie Williams el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Geoffrey Wheeler el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Alan Bell el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Nicholas Dunne el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Martin Holcombe el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mark Sidney Law el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Clare Gilhooly el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Penelope Jean Bainbridge el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Maria Gardiner el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Eleanor Botwright el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de BRITISH ASSOCIATION OF SETTLEMENTS AND SOCIAL ACTION CENTRES?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HUGHES, Benjamin Thomas
    8 Albion Square
    E8 4ES London
    Secretario
    8 Albion Square
    E8 4ES London
    BritishChief Executive104126620001
    BAINBRIDGE, Penelope Jean
    33 Vyner Street
    YO31 8HR York
    Director
    33 Vyner Street
    YO31 8HR York
    EnglandBritishManager60998270002
    BELL, Alan
    Ingledene
    Park Lane
    WF8 4QJ Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    Ingledene
    Park Lane
    WF8 4QJ Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritishChief Executive Of Development Trust70500140002
    BOTWRIGHT, Eleanor
    139 Henchman Street
    W12 0BN London
    Director
    139 Henchman Street
    W12 0BN London
    EnglandIrishCommunity Centre Director51653550001
    CORBETT BIRD, Julie
    26 Breer Street
    SW6 3HD London
    Director
    26 Breer Street
    SW6 3HD London
    EnglandBritishDirector Charity84607630001
    DUNNE, Nicholas
    20 Hillbury Road
    Tooting
    SW17 8JT London
    Director
    20 Hillbury Road
    Tooting
    SW17 8JT London
    EnglandBritishDirector Bede House Associatio86769730001
    FLAVIN, Nicholas Anthony
    Dunedin 39 Townfoot
    Stow
    TD1 2QN Galashiels
    Selkirkshire
    Director
    Dunedin 39 Townfoot
    Stow
    TD1 2QN Galashiels
    Selkirkshire
    ScotlandIrishCharity Executive1141160001
    GARDINER, Maria
    22 Green Lane
    Simmondley
    SK13 6XY Glossop
    Derbyshire
    Director
    22 Green Lane
    Simmondley
    SK13 6XY Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritishFinance Manager127103980001
    GILHOOLY, Clare
    26 Cadet Drive
    SE1 5RT London
    Director
    26 Cadet Drive
    SE1 5RT London
    EnglandBritishCharity Ceo54958740001
    HOLCOMBE, Martin Nicholas
    261 Selly Oak Road
    B30 1HR Birmingham
    West Midlands
    Director
    261 Selly Oak Road
    B30 1HR Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishChief Executive126172140001
    HOLMES, Joanna Susan
    11 Thingwall Park
    BS16 2AJ Bristol
    Avon
    Director
    11 Thingwall Park
    BS16 2AJ Bristol
    Avon
    EnglandBritishManager102526870001
    LAW, Mark Sidney
    268 Broad Lane
    Bramley
    LS13 2LA Leeds
    West Yorkshire
    Director
    268 Broad Lane
    Bramley
    LS13 2LA Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCeo79933890001
    LIBURD, Donna Alicia
    Flat 5
    103 Bravington Road
    W9 3AS London
    Director
    Flat 5
    103 Bravington Road
    W9 3AS London
    United KingdomBritishDirector98789750001
    MARRIOTT, Ruth Anne
    .
    East Taphouse
    PL14 4NJ Liskeard
    The Old Smithy
    Cornwall
    Director
    .
    East Taphouse
    PL14 4NJ Liskeard
    The Old Smithy
    Cornwall
    United KingdomEnglishChief Executive92749000001
    ROBINSON, Andrew John
    1 Wallcrouch Farm Cottage
    High Street Wallcrouch
    TN5 7JH Wadhurst
    East Sussex
    Director
    1 Wallcrouch Farm Cottage
    High Street Wallcrouch
    TN5 7JH Wadhurst
    East Sussex
    United KingdomBritishDirector Market Development54298980001
    TAYLOR, Marilyn Elaine
    Gathorne Road
    BS3 1LU Bristol
    54
    Director
    Gathorne Road
    BS3 1LU Bristol
    54
    United KingdomBritishResearcher68614020004
    WHEELER, Geoffrey
    17 Beech View
    BN16 4DE Angmering
    West Sussex
    Director
    17 Beech View
    BN16 4DE Angmering
    West Sussex
    EnglandBritishCertified150478480001
    WILLIAMS, Frankie
    Lowfield Road
    CV3 1LA Coventry
    32
    West Midlands
    Director
    Lowfield Road
    CV3 1LA Coventry
    32
    West Midlands
    EnglandBritishProject Manager117219780002
    MATTHEWS, John Frank
    1 Toby Road
    Lydd On Sea
    TN29 9PG Romney Marsh
    Kent
    Secretario
    1 Toby Road
    Lydd On Sea
    TN29 9PG Romney Marsh
    Kent
    British27427060002
    ADAMS, Kim Andrew
    100 Wilmot Street
    E2 6BT London
    Director
    100 Wilmot Street
    E2 6BT London
    BritishCommunity Worker92360750001
    BEE, William John
    Garden Flat
    16 Miles Road Clifton
    BS8 2JW Bristol
    Avon
    Director
    Garden Flat
    16 Miles Road Clifton
    BS8 2JW Bristol
    Avon
    BritishManager Voulntary Organisation33828700001
    BOATEMAH, Theodora
    99 Marston House
    Overton Road
    SW9 7HD London
    Director
    99 Marston House
    Overton Road
    SW9 7HD London
    BritishDirector33107640001
    BROOKE, Hilary
    10 Bearwood Corft
    Clayton Le Woods
    PR6 7SJ Chorley
    Lancashire
    Director
    10 Bearwood Corft
    Clayton Le Woods
    PR6 7SJ Chorley
    Lancashire
    BritishCharity Director35023890001
    CONTRERAS-RAMIREZ, Ana-Mae
    55 Formunt Close
    E16 1QR London
    Director
    55 Formunt Close
    E16 1QR London
    United KingdomFilipinoTeam Manager82756270001
    DEMPSEY, Nicholas Anthony
    53 Ashmead House
    Avonvale Road Barton Hill
    BS5 9ST Bristol
    Director
    53 Ashmead House
    Avonvale Road Barton Hill
    BS5 9ST Bristol
    EnglishCompany Director45366160001
    DERSLEY, Robert George
    10 Waverley Road
    TQ7 1EZ Kingsbridge
    Devon
    Director
    10 Waverley Road
    TQ7 1EZ Kingsbridge
    Devon
    BritishSettlement Director30182610001
    FARAHANI, Nasrin
    39 Rosebank
    Holyport Road
    SW6 6LQ London
    Director
    39 Rosebank
    Holyport Road
    SW6 6LQ London
    British IranianEducation & Training Manager73134570001
    FLAVIN, Nicholas Anthony
    Dunedin 39 Townfoot
    Stow
    TD1 2QN Galashiels
    Selkirkshire
    Director
    Dunedin 39 Townfoot
    Stow
    TD1 2QN Galashiels
    Selkirkshire
    ScotlandIrishDirector,Edinburgh University1141160001
    GEOGHEGAN, Luke, Rev Dr
    Gravel Path
    HP4 2EF Berkhamsted
    16
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Gravel Path
    HP4 2EF Berkhamsted
    16
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishWarden131566740001
    HANCOCK, Angela Elizabeth
    123 Hanworth House
    John Ruskin Street
    SE5 0XN London
    Director
    123 Hanworth House
    John Ruskin Street
    SE5 0XN London
    BritishCo-Ordinator45366110001
    HOLLINGSWORTH, Conrad
    65 Knowles Hill Crescent
    SE13 6DT London
    Director
    65 Knowles Hill Crescent
    SE13 6DT London
    BritishCharity Manager67689440002
    HOLNESS, Jakki Craig
    89 Ramilles Close
    Blenhiem Gardens Brixton
    SW2 5DQ Lambeth
    Director
    89 Ramilles Close
    Blenhiem Gardens Brixton
    SW2 5DQ Lambeth
    BritishProject Coordinator38875210001
    HOOPER, Geoffrey Michael, Reverend
    30 Avenons Road
    Plaistow
    E13 8HT London
    Director
    30 Avenons Road
    Plaistow
    E13 8HT London
    BritishCharity Director12688650001
    HOOPER, Geoffrey Michael, Reverend
    30 Avenons Road
    Plaistow
    E13 8HT London
    Director
    30 Avenons Road
    Plaistow
    E13 8HT London
    BritishSettlement Director12688650001
    JENKINS, Christina
    7 Grove Mansions
    Stamford Grove West
    N16 6LP London
    Director
    7 Grove Mansions
    Stamford Grove West
    N16 6LP London
    BritishAsst Charity Director50599340001

    ¿Tiene BRITISH ASSOCIATION OF SETTLEMENTS AND SOCIAL ACTION CENTRES alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 20 abr 2010
    Entregado el 21 abr 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £85,221 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property k/a ground floor premises, 33 corsham street, london t/no EGL490078 and includes all buildings, see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Charity Bank Limited
    Transacciones
    • 21 abr 2010Registro de un cargo (MG01)
    Legal charge
    Creado el 10 jun 2005
    Entregado el 14 jun 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £308,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Property k/a part ground floor, 33 corsham street, london floating charge all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment in or about the property and including any parts.
    Personas con derecho
    • Unity Trust Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jun 2005Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 10 jun 2005
    Entregado el 14 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £92,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Property k/a part ground floor, 33 corsham street, london floating charge all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment in or about the property and including any parts.
    Personas con derecho
    • The Trustees of the Esmee Fairbairn Foundation
    Transacciones
    • 14 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0