ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02869879 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 20 Montford Place Kennington SE11 5DE London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS PLC | 19 sept 1994 | 19 sept 1994 |
| HIRAM WALKER HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | 14 dic 1993 | 14 dic 1993 |
| ADVANCEISSUE PUBLIC LIMITED COMPANY | 08 nov 1993 | 08 nov 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 02 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 16 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 02 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Edward Fells como director el 28 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 26 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cambio de datos del director Catherine Louise Thompson el 30 sept 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 28 páginas | AA | ||||||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 02 nov 2023 | 3 páginas | RP04CS01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 nov 2023 sin actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||
| ||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 24 may 2023
| 4 páginas | SH01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 27 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cambio de datos del director Edward Fells el 19 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Cese del nombramiento de Stuart Macnab como director el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 28 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cambio de datos del director Catherine Louise Thompson el 01 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2020 | 25 páginas | AA | ||||||
Cambio de datos del director Edward Fells el 07 dic 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Modification des détails de Chivas Holdings (Ip) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||
Modification des détails de Allied Domecq (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||
Nombramiento de Edward Fells como director el 01 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Vincent Turpin como director el 30 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cese del nombramiento de Amanda Hamilton-Stanley como director el 01 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Modification des détails de Chivas Holdings Ip Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||
¿Quiénes son los directivos de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMILEY, Alexander Hugh | Secretario | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | 258907860001 | |||||||
| MCKECHNIE, Stuart Andrew Ferrie | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | Scotland | British | 264144930001 | |||||
| THOMPSON, Catherine Louise | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | France | Australian | 258897310003 | |||||
| BROWN, Charles Bennett | Secretario | The Old Library High Street BS40 5QA Wrington Bristol Avon | British | 107840600001 | ||||||
| EGAN, Jane | Secretario | 11 Mccrorie Place PA10 2BF Kilbarchan Renfrewshire | British | 112277750001 | ||||||
| FITZSIMONS, Ian Terence | Secretario | 5 Rue Gounod, 75017 Paris | British | 116030190001 | ||||||
| GILES, Nicholas David Martin | Secretario | Millbridge Cottage Redcliffe Street BS27 3ND Cheddar Somerset | British | 104193490001 | ||||||
| HUGHES, Sarah Helen | Secretario | 85 Devonshire Road Westbury Park BS6 7NH Bristol | British | 90664870001 | ||||||
| KELLEY, Russell Phelps | Secretario | 206 Sussex Mansions 71-77 Old Brompton Road SW7 3JZ London | United States | 68327770001 | ||||||
| MACNAB, Stuart | Secretario | 6 Station Rise PA12 4NA Lochwinnoch Renfrewshire | British | 77024740001 | ||||||
| MAPPLEBECK, Ailsa Mary Robertson | Secretario | Chivas House 72 Chancellors Road W6 9RS London | 168875270001 | |||||||
| MITCHELL, David Smith | Secretario | 16 Walpole Gardens TW2 5SJ Twickenham Middlesex | British | 1970560001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BABEAU, Emmanuel Andre Marie | Director | 7 Rue Paul Chatrousse, 92200 Neuilly Sur Seine France | French | 107414890001 | ||||||
| BOWMAN, Philip | Director | The Secretariat Department Allied Domecq Plc The Pavilions BS13 8AR Bridgwater Road Bedminster Down Bristol | Australian | 62693560005 | ||||||
| BROWN, Charles Bennett | Director | The Old Library High Street BS40 5QA Wrington Bristol Avon | British | 107840600001 | ||||||
| BURROWS, Richard | Director | Dunseverick, Coast Road IRISH Portmarnock County Dublin Ireland | Irish | 77905730001 | ||||||
| FELLS, Edward | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | United Kingdom | British | 274854930003 | |||||
| FETTER, Herve Denis Michel | Director | Spear Mews SW5 9NA London 6 | England | French | 133848930001 | |||||
| FITZSIMONS, Ian Terence | Director | 5 Fielding Road W4 1HP London | United Kingdom | British | 116030190003 | |||||
| FLAISSIER, Yves Virgile Michel | Director | 11 Chemin Du Parc De Charonne 75020 FOREIGN Paris | French | 107756520001 | ||||||
| HALES, Antony John | Director | Belvoir House Edstone Court Wootton Wawen B95 6DD Henley In Arden | United Kingdom | British | 14399520001 | |||||
| HAMILTON-STANLEY, Amanda | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | England | British | 128721240001 | |||||
| HETHERINGTON, Graham Charles | Director | Top Floor Flat 14-15 Weymouth Mews W1E 7EA London | British | 49219850002 | ||||||
| JETHA, Aziz | Director | 10 Grove Road HA5 5HW Pinner Middlesex | United Kingdom | British | 1186770001 | |||||
| LYSTER, Peter John | Director | Arch Barn Quarry Springs Goathurst TA5 2DH Bridgwater Somerset | England | British | 34011420003 | |||||
| MACFARLANE, Peter Froude | Director | Heath Hall Bowlhead Green GU8 6NW Godalming Surrey | British | 34011410004 | ||||||
| MACNAB, Stuart | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | United Kingdom | British | 77024740001 | |||||
| MITCHELL, David Smith | Director | 16 Walpole Gardens TW2 5SJ Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 1970560001 | |||||
| ORME, Howard Peter | Director | Deepdene Warren 28 Deepdene Drive RH5 4BB Dorking Surrey | United Kingdom | British | 105046690001 | |||||
| PORTA, Christian | Director | 4 Onslow Mews East SW7 3AA London | England | French | 94596140001 | |||||
| PRINGUET, Pierre | Director | 15 Avenue Robert Schuman 75007 Paris France | France | French | 82221780001 | |||||
| RICARD, Patrick | Director | 17 Rue Cassette FOREIGN 75006 Paris France | French | 107540040001 | ||||||
| SCHOFIELD, Anthony | Director | Lomond House 9 Zetland Place EH5 3HU Edinburgh | United Kingdom | British | 53680030002 | |||||
| STAGG, Kelvin John | Director | 1 Repton Hall Carriage Drive BS10 6TE Royal Victoria Park Avon | British | 101213810001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chivas Holdings (Ip) Limited | 06 abr 2016 | Stirling Road G82 2SS Dumbarton Kilmalid Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Allied Domecq (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0