BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED

BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02873670
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    • fabricación de perfumes y preparados de tocador (20420) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    New Kings Court Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HAMPSHIRE COSMETICS LIMITED27 oct 199427 oct 1994
    RIDGEROW LIMITED19 nov 199319 nov 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Wystan Corporate Services Limited como director el 26 sept 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Wystan Holdings Inc como director el 26 sept 2018

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    49 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Decisions and resolutions ratified and approved 22/08/2018
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Wystan Holdings Inc como director el 22 ago 2018

    2 páginasAP02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2016

    4 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 nov 2015

    Estado de capital el 20 nov 2015

    • Capital: GBP 1,650,200
    SH01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    AA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Déclaration annuelle établie au 19 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 dic 2014

    Estado de capital el 05 dic 2014

    • Capital: GBP 1,650,200
    SH01

    Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa

    1 páginasDS02

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado de capital el 15 ene 2014

    • Capital: GBP 200
    4 páginasSH19

    ¿Quiénes son los directivos de BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1914417
    38915800008
    SMITH, Adrian Holmes
    St Ives Park
    BN24 2JX Ringwood
    57
    Hampshire
    Director
    St Ives Park
    BN24 2JX Ringwood
    57
    Hampshire
    United KingdomBritish51302090001
    BLAND, Michael James
    Apartado 3531
    8135 Almancil
    Portugal
    Secretario
    Apartado 3531
    8135 Almancil
    Portugal
    British94686660002
    SANDERS, Robert Braith Charles
    Waterberry Drive
    PO7 7YW Waterlooville
    Brambles House
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    Waterberry Drive
    PO7 7YW Waterlooville
    Brambles House
    Hampshire
    United Kingdom
    149449750001
    YOUNGER, Marilyn Claire
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    Secretario
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    British38965710001
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1914417
    38915800008
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Secretario designado corporativo
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001990001
    DARKE, Charles Peter
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritish61772430003
    HARDY, Audrey Sylvia
    4201 Kean Road
    33314 Port Lauderdale
    Florida
    Director
    4201 Kean Road
    33314 Port Lauderdale
    Florida
    British39006670002
    HAYWOOD, Julia Louise
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritish160954760001
    JORDAN, Nicola
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish160951730001
    POLDING, Mark
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish160951850001
    SANDERS, Robert Braith Charles
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish70944840001
    SPERRING, Mark Anthony
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish160951960001
    VINE, David Graham
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish160952040001
    WAITE, Thomas Edward
    4201 Kean Road
    33314 Fort Lauderdale
    Florida
    Usa
    Director
    4201 Kean Road
    33314 Fort Lauderdale
    Florida
    Usa
    British39006760002
    YOUNGER, Marilyn Claire
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    Director
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    British38965710001
    YOUNGER, Marilyn Claire
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    Director
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    British38965710001
    YOUNGER, Paul Owen
    Church Road
    Newtown
    PO17 6LA Fareham
    The Grange
    Hampshire
    Director
    Church Road
    Newtown
    PO17 6LA Fareham
    The Grange
    Hampshire
    EnglandBritish6788640001
    ALDEBURGH ENTERPRISES LIMITED
    Suite 2a Eurolife Building
    1 Corral Road
    FOREIGN Gibraltar
    Director corporativo
    Suite 2a Eurolife Building
    1 Corral Road
    FOREIGN Gibraltar
    46113110001
    BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Director designado corporativo
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001980001
    C L CLEMO & CO CORPORATE SERVICES LIMITED
    88 Copse Hill
    Wimbledon Common
    SW20 0EF London
    Director corporativo
    88 Copse Hill
    Wimbledon Common
    SW20 0EF London
    42479600001
    NEW CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    P.O. Box 146 Roadtown
    Tortola
    FOREIGN British Virgin Islands
    Director corporativo
    P.O. Box 146 Roadtown
    Tortola
    FOREIGN British Virgin Islands
    48067050001
    WYSTAN CORPORATE SERVICES LIMITED
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Turks And Caicos Islands
    Director corporativo
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Turks And Caicos Islands
    Forma jurídicaEXEMPTED COMPANY
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalTHE COMPANIES ORDANCE 1981
    Número de registroE39405
    174566920001
    WYSTAN CORPORATE SERVICES LIMITED
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Bwi
    Turks & Caicos Islan
    Director corporativo
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Bwi
    Turks & Caicos Islan
    Forma jurídicaEXEMPTED COMPANY
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalTHE COMPANIES ORDINANCE 1981
    Número de registroE.39405
    145995950001
    WYSTAN HOLDINGS INC
    Leeward Highway
    Providenciales
    PO BOX 267, Bcm Cape Building
    Turks And Caicos Islands
    Director corporativo
    Leeward Highway
    Providenciales
    PO BOX 267, Bcm Cape Building
    Turks And Caicos Islands
    Forma jurídicaCORPORATE
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalTURKS AND CAICOS ISLANDS
    Número de registro29228
    249686940001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06237275
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Chattels mortgage
    Creado el 19 ago 2011
    Entregado el 20 ago 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Asset name vibratory bowl feeder (model avb 460F) serial number AS496. Sleevit sleevemaster serial number SM850. Beltorgue cup tighting machine mode bt-st serial J10-015.00.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD and Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transacciones
    • 20 ago 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 19 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    Creado el 05 jul 2011
    Entregado el 07 jul 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transacciones
    • 07 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 19 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal assignment
    Creado el 28 jun 2011
    Entregado el 29 jun 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 29 jun 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 19 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 14 jun 2011
    Entregado el 15 jun 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 15 jun 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 19 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    All assets debenture
    Creado el 24 nov 2008
    Entregado el 26 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Venture Finance PLC
    Transacciones
    • 26 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 02 sept 1996
    Entregado el 10 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a loan agreement of even date or the mortgage debenture
    Breve descripción
    L/H property k/a brambles house, waterberry drive, waterlooville hampshire t/no: HP414945 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hampshire Cosmetic Laboratories Limited
    Transacciones
    • 10 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 02 jun 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 14 nov 1994
    Entregado el 21 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 14 nov 1994
    Entregado el 21 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property k/as brambles house waterberry drive waterlooville hampshire.t/no.HP414945 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0