LEASING DECEMBER (14) LIMITED

LEASING DECEMBER (14) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLEASING DECEMBER (14) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02876243
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Oak Green House, 250-256 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DRESDNER KLEINWORT LEASING DECEMBER (14) LIMITED18 sept 200618 sept 2006
    ABBEY NATIONAL SEPTEMBER LEASING (6) LTD23 dic 199323 dic 1993
    ALLREJECT COMPANY LIMITED29 nov 199329 nov 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jonathon Paul Sowton como director el 30 jun 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Martin John Sockett como director el 27 jun 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    9 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Grafton Group Secretarial Services Limited el 31 dic 2020

    2 páginasCH04

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    10 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 ene 2016

    Estado de capital el 04 ene 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nombramiento de Brian O'hara como director el 07 may 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Brian Hodgkiss como director el 30 abr 2015

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GRAFTON GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Heron House
    Corrig Road Sandyford Industrial Estate
    Dublin 18
    Co/Grafton Group Plc
    Ireland
    Secretario corporativo
    Heron House
    Corrig Road Sandyford Industrial Estate
    Dublin 18
    Co/Grafton Group Plc
    Ireland
    Forma jurídicaPRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
    Tipo de identificaciónOtra entidad corporativa o firma
    Autoridad legalIRISH COMPANIES ACT 2014
    Número de registro243716
    97259990001
    O'HARA, Brian
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Director
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish189958690001
    SOCKETT, Martin John, Mr.
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6LW Birmingham
    Ground Floor, Boundary House
    England
    Director
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6LW Birmingham
    Ground Floor, Boundary House
    England
    EnglandBritish291426940001
    DANIEL, Irina Marsovna
    Flat 1
    9 Cromwell Place
    SW7 2JN London
    Secretario
    Flat 1
    9 Cromwell Place
    SW7 2JN London
    British113609450004
    LONGCROFT, Peter Leonard
    4 Lakeside Close
    Reydon
    IP18 6YA Southwold
    Suffolk
    Secretario
    4 Lakeside Close
    Reydon
    IP18 6YA Southwold
    Suffolk
    British32431030003
    STEVENS, Andrew John
    3 Holly Cottages
    East End Lane
    CO7 6XG East Bergholt
    Essex
    Secretario
    3 Holly Cottages
    East End Lane
    CO7 6XG East Bergholt
    Essex
    British103050090001
    WALL, James Cameron
    95 Willow Park
    Otford
    TN14 5NF Sevenoaks
    Kent
    Secretario
    95 Willow Park
    Otford
    TN14 5NF Sevenoaks
    Kent
    British11724060005
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey House Baker Street
    Baker Street
    NW1 6XL London
    Secretario corporativo
    Abbey House Baker Street
    Baker Street
    NW1 6XL London
    61749570001
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Secretario corporativo
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AIKEN, Neil Gordon
    The Birches 14 Stradbroke Drive
    IG7 5QX Chigwell
    Essex
    Director
    The Birches 14 Stradbroke Drive
    IG7 5QX Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish43380390001
    BATCHELOR, Gwendoline Mary
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    Director
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    British34184100001
    BATCHELOR, Gwendoline Mary
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    Director
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    British34184100001
    BIRCH, Richard Alastair
    61 Fishpool Street
    AL3 4RU St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    61 Fishpool Street
    AL3 4RU St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish152524800001
    COHEN, Jonathan Paul
    13 Gowan Lea
    15 Woodford Road
    E18 2ER London
    Director
    13 Gowan Lea
    15 Woodford Road
    E18 2ER London
    EnglandBritish26953400001
    EDWARDS, Shirley Ann Elizabeth
    Tilbrook Mill
    Lower Dean
    PE28 0LH Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Tilbrook Mill
    Lower Dean
    PE28 0LH Huntingdon
    Cambridgeshire
    British61855020002
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Director
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    FANE DE SALIS, Henrietta Frances Jane
    52 Colebrooke Row
    N1 8AF London
    Director
    52 Colebrooke Row
    N1 8AF London
    British100519650004
    GARRATT, Robin
    Wansunt Road
    DA5 2DN Bexley
    107
    Kent
    Director
    Wansunt Road
    DA5 2DN Bexley
    107
    Kent
    EnglandBritish14290340001
    GREEN, David Martin
    7 Restharrow Road
    Weavering
    ME14 5UH Maidstone
    Kent
    Director
    7 Restharrow Road
    Weavering
    ME14 5UH Maidstone
    Kent
    British83033800001
    HODGKISS, Brian
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House, 250-256 High Street
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House, 250-256 High Street
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish37164140002
    HUTCHISON, Sarah Anne
    77 Parliament Hill
    NW3 2TH London
    Director
    77 Parliament Hill
    NW3 2TH London
    British36372610001
    JONES, David Gareth
    Hillhouse Farm
    Misbrooks Green Road Beare Green
    RH5 4QQ Dorking
    Surrey
    Director
    Hillhouse Farm
    Misbrooks Green Road Beare Green
    RH5 4QQ Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish6205890002
    JULIAN, Suzanne Margaret
    25 Quick Road
    Chiswick
    W4 2BU London
    Director
    25 Quick Road
    Chiswick
    W4 2BU London
    British36432460001
    LEVY, Anthony David
    59 Daneland
    EN4 8PZ East Barnet
    Hertfordshire
    Director
    59 Daneland
    EN4 8PZ East Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish98888430001
    LONG, Graham Stephen
    22 Cumberland Road
    SW13 9LY London
    Director
    22 Cumberland Road
    SW13 9LY London
    British38022070005
    LOWE, William Nairn
    Briar Gap
    Loseberry Road
    KT10 9DQ Claygate
    Surrey
    Director
    Briar Gap
    Loseberry Road
    KT10 9DQ Claygate
    Surrey
    EnglandBritish282371920001
    MERRICK, Anna
    27 Jacksons Lane
    Highgate
    N6 5SR London
    Director
    27 Jacksons Lane
    Highgate
    N6 5SR London
    British39621110002
    MIDDLETON, Kevin Paul
    Canwick Road
    1224
    LN5 5NH Lincoln
    Pelham House
    England
    Director
    Canwick Road
    1224
    LN5 5NH Lincoln
    Pelham House
    England
    EnglandBritish61374610002
    NICHOLLS, Jonathan Clive
    Longmeadow
    Prinsted Lane
    PO10 8HR Emsworth
    Hampshire
    Director
    Longmeadow
    Prinsted Lane
    PO10 8HR Emsworth
    Hampshire
    United KingdomEnglish127532290001
    O'DONOVAN, Colin
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Director
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish164508820001
    O'NUALLAIN, Colm
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    Director
    Heron House
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    C/O Grafton Group Plc
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish79602480001
    PARES, Michael
    Canwick Road
    1224
    LN5 5NH Lincoln
    Pelham House
    England
    Director
    Canwick Road
    1224
    LN5 5NH Lincoln
    Pelham House
    England
    EnglandBritish21670040001
    SOWTON, Jonathon Paul
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House, 250-256 High Street
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House, 250-256 High Street
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish151407670001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Grafton Group (Uk) Plc
    250-256 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House
    Surrey
    England
    06 abr 2016
    250-256 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House
    Surrey
    England
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro02886378
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene LEASING DECEMBER (14) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Lease security assignment
    Creado el 26 sept 2007
    Entregado el 04 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Assign absolutely and unconditionally the rental property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transacciones
    • 04 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over bank account
    Creado el 26 sept 2007
    Entregado el 04 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All present and future right title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transacciones
    • 04 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Lease security assignment
    Creado el 26 sept 2007
    Entregado el 04 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Assign absolutely and unconditionally the rental property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transacciones
    • 04 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over bank account
    Creado el 26 sept 2007
    Entregado el 04 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transacciones
    • 04 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Headlease security assignment
    Creado el 26 sept 2007
    Entregado el 04 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Assign absolutely and unconditionally the headlease property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transacciones
    • 04 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over bank account
    Creado el 26 sept 2007
    Entregado el 04 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transacciones
    • 04 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0