LEASING DECEMBER (14) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LEASING DECEMBER (14) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02876243 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?
- Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra LEASING DECEMBER (14) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Oak Green House, 250-256 High Street RH4 1QT Dorking Surrey |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DRESDNER KLEINWORT LEASING DECEMBER (14) LIMITED | 18 sept 2006 | 18 sept 2006 |
| ABBEY NATIONAL SEPTEMBER LEASING (6) LTD | 23 dic 1993 | 23 dic 1993 |
| ALLREJECT COMPANY LIMITED | 29 nov 1993 | 29 nov 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEASING DECEMBER (14) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathon Paul Sowton como director el 30 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Martin John Sockett como director el 27 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Grafton Group Secretarial Services Limited el 31 dic 2020 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Brian O'hara como director el 07 may 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Brian Hodgkiss como director el 30 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAFTON GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18 Co/Grafton Group Plc Ireland |
| 97259990001 | ||||||||||||||
| O'HARA, Brian | Director | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | 189958690001 | |||||||||||||
| SOCKETT, Martin John, Mr. | Director | Wythall Green Way Wythall B47 6LW Birmingham Ground Floor, Boundary House England | England | British | 291426940001 | |||||||||||||
| DANIEL, Irina Marsovna | Secretario | Flat 1 9 Cromwell Place SW7 2JN London | British | 113609450004 | ||||||||||||||
| LONGCROFT, Peter Leonard | Secretario | 4 Lakeside Close Reydon IP18 6YA Southwold Suffolk | British | 32431030003 | ||||||||||||||
| STEVENS, Andrew John | Secretario | 3 Holly Cottages East End Lane CO7 6XG East Bergholt Essex | British | 103050090001 | ||||||||||||||
| WALL, James Cameron | Secretario | 95 Willow Park Otford TN14 5NF Sevenoaks Kent | British | 11724060005 | ||||||||||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Abbey House Baker Street Baker Street NW1 6XL London | 61749570001 | |||||||||||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||||||
| AIKEN, Neil Gordon | Director | The Birches 14 Stradbroke Drive IG7 5QX Chigwell Essex | United Kingdom | British | 43380390001 | |||||||||||||
| BATCHELOR, Gwendoline Mary | Director | 26 Crescent Wood Road SE26 6RU London | British | 34184100001 | ||||||||||||||
| BATCHELOR, Gwendoline Mary | Director | 26 Crescent Wood Road SE26 6RU London | British | 34184100001 | ||||||||||||||
| BIRCH, Richard Alastair | Director | 61 Fishpool Street AL3 4RU St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 152524800001 | |||||||||||||
| COHEN, Jonathan Paul | Director | 13 Gowan Lea 15 Woodford Road E18 2ER London | England | British | 26953400001 | |||||||||||||
| EDWARDS, Shirley Ann Elizabeth | Director | Tilbrook Mill Lower Dean PE28 0LH Huntingdon Cambridgeshire | British | 61855020002 | ||||||||||||||
| ELLIS, David James | Director | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||||||||||
| FANE DE SALIS, Henrietta Frances Jane | Director | 52 Colebrooke Row N1 8AF London | British | 100519650004 | ||||||||||||||
| GARRATT, Robin | Director | Wansunt Road DA5 2DN Bexley 107 Kent | England | British | 14290340001 | |||||||||||||
| GREEN, David Martin | Director | 7 Restharrow Road Weavering ME14 5UH Maidstone Kent | British | 83033800001 | ||||||||||||||
| HODGKISS, Brian | Director | RH4 1QT Dorking Oak Green House, 250-256 High Street Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 37164140002 | |||||||||||||
| HUTCHISON, Sarah Anne | Director | 77 Parliament Hill NW3 2TH London | British | 36372610001 | ||||||||||||||
| JONES, David Gareth | Director | Hillhouse Farm Misbrooks Green Road Beare Green RH5 4QQ Dorking Surrey | United Kingdom | British | 6205890002 | |||||||||||||
| JULIAN, Suzanne Margaret | Director | 25 Quick Road Chiswick W4 2BU London | British | 36432460001 | ||||||||||||||
| LEVY, Anthony David | Director | 59 Daneland EN4 8PZ East Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 98888430001 | |||||||||||||
| LONG, Graham Stephen | Director | 22 Cumberland Road SW13 9LY London | British | 38022070005 | ||||||||||||||
| LOWE, William Nairn | Director | Briar Gap Loseberry Road KT10 9DQ Claygate Surrey | England | British | 282371920001 | |||||||||||||
| MERRICK, Anna | Director | 27 Jacksons Lane Highgate N6 5SR London | British | 39621110002 | ||||||||||||||
| MIDDLETON, Kevin Paul | Director | Canwick Road 1224 LN5 5NH Lincoln Pelham House England | England | British | 61374610002 | |||||||||||||
| NICHOLLS, Jonathan Clive | Director | Longmeadow Prinsted Lane PO10 8HR Emsworth Hampshire | United Kingdom | English | 127532290001 | |||||||||||||
| O'DONOVAN, Colin | Director | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | 164508820001 | |||||||||||||
| O'NUALLAIN, Colm | Director | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | 79602480001 | |||||||||||||
| PARES, Michael | Director | Canwick Road 1224 LN5 5NH Lincoln Pelham House England | England | British | 21670040001 | |||||||||||||
| SOWTON, Jonathon Paul | Director | RH4 1QT Dorking Oak Green House, 250-256 High Street Surrey United Kingdom | England | British | 151407670001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LEASING DECEMBER (14) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafton Group (Uk) Plc | 06 abr 2016 | 250-256 High Street RH4 1QT Dorking Oak Green House Surrey England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene LEASING DECEMBER (14) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Lease security assignment | Creado el 26 sept 2007 Entregado el 04 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Assign absolutely and unconditionally the rental property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over bank account | Creado el 26 sept 2007 Entregado el 04 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All present and future right title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Lease security assignment | Creado el 26 sept 2007 Entregado el 04 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Assign absolutely and unconditionally the rental property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over bank account | Creado el 26 sept 2007 Entregado el 04 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Headlease security assignment | Creado el 26 sept 2007 Entregado el 04 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company formerly known as dresdner kleinwort leasing december (14) limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Assign absolutely and unconditionally the headlease property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over bank account | Creado el 26 sept 2007 Entregado el 04 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0