TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED

TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02876730
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    110 Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INTERNET RECRUITMENT GROUP LIMITED08 ene 199808 ene 1998
    INTERNET CONTRACT SERVICES LIMITED01 dic 199301 dic 1993

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cancelación total de la carga 3

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    2 páginasMR04

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 30 oct 2017

    • Capital: GBP 2
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of the share premium account 27/10/2017
    RES13

    Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Notification de Harvey Nash Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    1 páginasPSC02

    Nombramiento de Mark Jonathan Garratt como director el 27 abr 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mark Jonathan Garratt como secretario el 27 abr 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jonathan Richard Ashcroft como director el 27 abr 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Richard Ashcroft como secretario el 27 abr 2017

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2016

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 jul 2016

    Estado de capital el 04 jul 2016

    • Capital: GBP 173,507.3
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2015

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 nov 2015

    Estado de capital el 02 nov 2015

    • Capital: GBP 173,507.3
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 01 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 dic 2014

    Estado de capital el 24 dic 2014

    • Capital: GBP 173,507.3
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2014

    16 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Harvey Nash Heron Tower 110 Bishopsgate London England and Wales EC2N 4AY a 110 Bishopsgate London EC2N 4AY el 22 sept 2014

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 01 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 nov 2013

    Estado de capital el 08 nov 2013

    • Capital: GBP 173,507.3
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2013

    13 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Secretario
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    231362320001
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director49452080003
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Director
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector229682100001
    WASSALL, Simon Mark
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    Director
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector108449780001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretario
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    British258414370001
    BROADFOOT, Victoria Louise
    8 Aigburth Mansions
    Mowll Street Vauxhall
    SW9 0EP London
    Secretario
    8 Aigburth Mansions
    Mowll Street Vauxhall
    SW9 0EP London
    British56121450002
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Secretario
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director49452080003
    LINCOLN, Simon Paul
    94 Fentiman Road
    Vauxhall
    SW8 1LA London
    Secretario
    94 Fentiman Road
    Vauxhall
    SW8 1LA London
    BritishSalesman37131030001
    STEVENS, Paul John
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    Secretario
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    British36606580005
    WEST, Ashley Brendon George
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    Secretario
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    BritishAccountant58376020002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director258414370001
    BEEKE, Paul Lincoln
    Apartment 9n
    New York
    Ny 10013
    U S A
    Director
    Apartment 9n
    New York
    Ny 10013
    U S A
    BritishManagement Consultant60439120004
    CRAWFORD, Thomas Francis Alexander
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    Director
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    United KingdomBritishCompany Director3856480002
    FURNISS, Ian William
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    Director
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director81663830001
    GOODMAN, Andrew Graham
    The Pound House
    46 Totteridge Village
    N20 8PR London
    Director
    The Pound House
    46 Totteridge Village
    N20 8PR London
    United KingdomBritishConsultant57773080002
    HEATH, James Edward
    87 Langham Road
    TW11 9HG Teddington
    Middlesex
    Director
    87 Langham Road
    TW11 9HG Teddington
    Middlesex
    BritishChartered Accountant1329740003
    HIGGINS, David Charles
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    Director
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    United KingdomBritishCompany Director33333910003
    STEVENS, Paul John
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    Director
    Rosemary Cottages
    Stocklands Green Road
    TN3 0TS Speldhurst
    Kent
    EnglandBritishRecruitment Consultant36606580005
    TICE, Trevor Anthony
    1364 Union Street C
    San Francisco Ca 94109
    Usa
    Director
    1364 Union Street C
    San Francisco Ca 94109
    Usa
    AmericanManagement Consultant61254610001
    WEST, Ashley Brendon George
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    Director
    Cranmore House Blackhall Lane
    TN15 0HL Sevenoaks
    Kent
    BritishAccountant58376020002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3320790
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene TECHPARTNERS INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 05 jun 2002
    Entregado el 13 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 ene 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 24 mar 2000
    Entregado el 31 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Barclays bank PLC re techpartners international limited business premium account number 00453471 and barclays bank PLC re techpartners international limited barclays united states dollar deposit account number 49916766. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 04 ene 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    Creado el 16 nov 1998
    Entregado el 25 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed equitable charge over all debts purchased pursuant to the agreement with all related rights thereto and all amounts of indebtedness owing or becoming due to the company; floating charge over monies received in respect of the debts.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 25 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 04 ene 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 12 abr 1994
    Entregado el 13 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future and a floating charge on all book debts and other debts.
    Personas con derecho
    • Close Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 13 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 ago 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0